Actos BORME de Pizarras Del Valle Sl
28 de Noviembre de 2023Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 936 , F 26, S 8, H OR 13109, I/A 19 (21.11.23).
15 de Marzo de 2023Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 936 , F 26, S 8, H OR 13109, I/A 18 ( 2.03.23).
18 de Enero de 2022Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 823 , F 30, S 8, H OR 13109, I/A 17 ( 5.01.22).
30 de Julio de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER. Secretario: FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER. Cons.Del.Sol:FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER. Consejero: COBO ARIAS VICTOR MIGUEL. Cons.Del.Sol: COBO ARIAS VICTOR MIGUEL.Consejero: CUPIRE PADESA SL;CUPA PIZARRAS SA. Presidente: CUPA PIZARRAS SA. Nombramientos. Adm. Unico: CUPIREPADESA SL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datosregistrales. T 823 , F 30, S 8, H OR 13109, I/A 16 (23.07.21).
23 de Julio de 2021Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ FERNANDEZ AURELIANO. Datos registrales. T 823 , F 30, S 8, H OR 13109, I/A 15(15.07.21).
17 de Febrero de 2020Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 823 , F 30, S 8, H OR 13109, I/A 14 ( 3.02.20).
30 de Enero de 2017Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 823 , F 30, S 8, H OR 13109, I/A 13 ( 5.01.17).
21 de Septiembre de 2016Nombramientos. Apoderado: MERA CORES EDUARDO MANUEL. Datos registrales. T 823 , F 29, S 8, H OR 13109, I/A 12 (9.09.16).
23 de Diciembre de 2014P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 823 , F 29, S 8, H OR 13109, I/A 11 (15.12.14).
05 de Diciembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ GAYOSO ULPIANO;FERNANDEZ GARCIA AURELIANO. Presidente: RODRIGUEZGAYOSO ULPIANO. Cons.Del.Sol: RODRIGUEZ GAYOSO ULPIANO. Vicepresid.: FERNANDEZ GARCIA AURELIANO.Nombramientos. Consejero: CUPIRE PADESA SL;CUPA PIZARRAS SA. Presidente: CUPA PIZARRAS SA. Datos registrales. T823 , F 28, S 8, H OR 13109, I/A 10 (18.11.14).
13 de Septiembre de 2013Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 823 , F 28, S 8, H OR 13109, I/A 9 (30.08.13).
26 de Febrero de 2013Nombramientos. Apoderado: TRINCADO FERNANDEZ ANTONIO. Datos registrales. T 823 , F 27, S 8, H OR 13109, I/A 8(15.02.13).
28 de Febrero de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 821.570,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.223.426,00 Euros. Datos registrales. T 817 , F 162, S 8, HOR 13109, I/A 7 ( 3.02.12).
07 de Febrero de 2012Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ FERNANDEZ AURELIANO. Datos registrales. T 817 , F 159, S 8, H OR 13109, I/A 3 (5.01.12).
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ CARRERA ALEJANDRO. Datos registrales. T 817 , F 160, S 8, H OR 13109, I/A 4 (5.01.12).
Nombramientos. Apoderado: VOCES SIERRA DAVID. Datos registrales. T 817 , F 161, S 8, H OR 13109, I/A 5 ( 9.01.12).
30 de Enero de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 100.464,00 Euros. Resultante Suscrito: 401.856,00 Euros. Datos registrales. T 817 , F 162, S 8, HOR 13109, I/A 6 (16.01.12).
23 de Agosto de 2011Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 24.06.11. Objeto social: La explotaci贸n de piedra natural en su ciclo completo, es decir, laextracci贸n, preparaci贸n, industrializaci贸n y comercializaci贸n de la misma, ya seaen canteras propias, arrendadas o de cualquier otraforma. La gesti贸n de una cartera de valores, por cuenta propia, con excepci贸n de la intermediaci贸n. Domicilio: LUGAR A MEDUA S/N -CARBALLEDA DE VALDEORRAS (CARBALLEDA DE VALDEORRAS). Capital: 124.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad.Socio 煤nico: PIZARRAS LOS GALLOS SL. Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ GAYOSO ULPIANO. Presidente:RODRIGUEZ GAYOSO ULPIANO. Cons.Del.Sol: RODRIGUEZ GAYOSO ULPIANO. Consejero: FERNANDEZ GARCIA AURELIANO.Vicepresid.: FERNANDEZ GARCIA AURELIANO. Consejero: FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER. Secretario: FERNANDEZFERNANDEZ JAVIER. Cons.Del.Sol: FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER. Consejero: COBO ARIAS VICTOR MIGUEL. Cons.Del.Sol:COBO ARIAS VICTOR MIGUEL. Datos registrales. T 817 , F 157, S 8, H OR 13109, I/A 1 (28.07.11).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 177.392,00 Euros. Resultante Suscrito: 301.392,00 Euros. Datos registrales. T 817 , F 158, S 8, HOR 13109, I/A 2 (28.07.11).