Actos BORME de Pj España Pizzerias Sl
03 de Mayo de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: SOLANILLA CENDRERO JOSEFA. Datos registrales. T 41092 , F 212, S 8, H M 606008, I/A 56(25.04.22).
20 de Diciembre de 2021Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ DE LEON EDUARDO. Datos registrales. T 41092 , F 204, S 8, H M 606008, I/A 46(13.12.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ RUIZ JAVIER ALFREDO. Apo.Sol.: GONZALEZ RUIZ JAVIER ALFREDO. Datosregistrales. T 41092 , F 204, S 8, H M 606008, I/A 47 (13.12.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: ORTEGA MILLAN ROSA MARIA. Datos registrales. T 41092 , F 207, S 8, H M 606008, I/A 48(13.12.21).
Nombramientos. Apo.Manc.: SANHUEZA CAMPOS JOSE MIGUEL;BAS LOSTAO PABLO;CAÑAS HERNANDEZ JAVIER;ORTEGAMILLAN ROSA MARIA. Datos registrales. T 41092 , F 207, S 8, H M 606008, I/A 49 (13.12.21).
Revocaciones. Apoderado: OLAVE MARTIN JUAN;OLAVE MARTIN JUAN. Datos registrales. T 41092 , F 208, S 8, H M 606008,I/A 50 (13.12.21).
20 de Abril de 2021Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 41092 , F 204, S 8, H M 606008, I/A 45 (13.04.21).
09 de Abril de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: MENENDEZ SUERO JOAQUIN. Apoderado: MENENDEZ SUERO JOAQUIN. Nombramientos.Apo.Man.Soli: CAÑAS HERNANDEZ JAVIER. Datos registrales. T 41092 , F 201, S 8, H M 606008, I/A 44 (31.03.21).
25 de Enero de 2021Nombramientos. Apoderado: ASENSIO GARULO MARIA ARANZAZU. Datos registrales. T 41092 , F 195, S 8, H M 606008, I/A 35(18.01.21).
Nombramientos. Apoderado: GONZALO RAMOS EDUARDO. Datos registrales. T 41092 , F 197, S 8, H M 606008, I/A 36(18.01.21).
Nombramientos. Apoderado: MENENDEZ SUERO JOAQUIN. Datos registrales. T 41092 , F 197, S 8, H M 606008, I/A 37(18.01.21).
Nombramientos. Apoderado: PEREZ MUÑOZ JORGE. Datos registrales. T 41092 , F 198, S 8, H M 606008, I/A 38 (18.01.21).
Nombramientos. Apoderado: MENENDEZ VITERI MARIA. Datos registrales. T 41092 , F 198, S 8, H M 606008, I/A 39 (18.01.21).
Nombramientos. Apoderado: MONTERO MUÑOZ LAURA. Datos registrales. T 41092 , F 198, S 8, H M 606008, I/A 40 (18.01.21).
Nombramientos. Apoderado: MARTIN DEL RIO PABLO. Datos registrales. T 41092 , F 199, S 8, H M 606008, I/A 41 (18.01.21).
Nombramientos. Apoderado: ORTEGA MILLAN ROSA MARIA. Datos registrales. T 41092 , F 200, S 8, H M 606008, I/A 42(18.01.21).
Nombramientos. Apoderado: ESPESO MARTINEZ CARLOS;GARCIA MARTIN LETICIA;DOBRE MIRCEA;PEREZ MUÑOZ JOSEANTONIO. Datos registrales. T 41092 , F 200, S 8, H M 606008, I/A 43 (18.01.21).
22 de Enero de 2021Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MORA MORAES PIRES DE CARVALHO CAROLINA. Nombramientos. SecreNoConsj:LACAMBRA RIERA ERNESTO. VsecrNoConsj: RADOVANOVIC DRNDA BOJAN. Apoderado: OLAVE MARTIN JUAN;OLAVEMARTIN JUAN. Cambio de domicilio social. AVDA AJALVIR 46 (ALCALA DE HENARES). Datos registrales. T 35437 , F 128, S 8,H M 606008, I/A 31 (15.01.21).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MORA MORAES PIRES DE CARVALHO CAROLINA. Apo.Sol.: MORA MORAES PIRES DECARVALHO CAROLINA. Datos registrales. T 35437 , F 131, S 8, H M 606008, I/A 32 (15.01.21).
Nombramientos. Apoderado: BAS LOSTAO PABLO;BAS LOSTAO PABLO. Datos registrales. T 35437 , F 132, S 8, H M 606008,I/A 33 (15.01.21).
Revocaciones. Apo.Sol.: FERRER FERRER RUBEN;ERLAIZ COTELO IÑIGO;RIOPEREZ GALLEGOS DAVID. Apoderado: TERUELLOPEZ IRENE;SCHAAR ORIVE SAMARA. Apo.Man.Soli: VIAL CATALINA SILVA. Apo.Sol.: ABASOLO PEREZ ISABEL;BENITEZGOMEZ DANIEL;MARTIN FIDALGO REBECA. Apo.Man.Soli: ARANGUIZ GIGLIO JAVIER VICENTE. Apo.Sol.: FERNANDEZ-GAYTAN HERNANDEZ DANIEL;ROMERO MARQUEZ MACARENA ROCIO. Datos registrales. T 41092 , F 195, S 8, H M 606008,I/A 34 (15.01.21).
28 de Noviembre de 2019Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: DRAKE RESTAURANTES Y SERVICIOS ETVE SL. Datosregistrales. T 35437 , F 126, S 8, H M 606008, I/A 26 (21.11.19).