Actos BORME de Plasticos Brello Sa
27 de Octubre de 2023Transformaci贸n de sociedad. Denominaci贸n y forma adoptada: PLASTICOS BRELLO SL. Ceses/Dimisiones. Vicepresid.:BRETON LANGAS ANA ISABEL. Con.Delegado: BRETON LANGAS ANA ISABEL. Consejero: BRETON LANGAS ANA ISABEL.Secretario: BRETON LANGAS RICARDO. Consejero: BRETON LANGAS RICARDO. Presidente: GONZALEZ VALDERREY IKER.Con.Delegado: GONZALEZ VALDERREY IKER. Consejero: GONZALEZ VALDERREY IKER. Con.Delegado: BRETON LANGASRICARDO. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ VALDERREY IKER;BRETON LANGAS RICARDO;BRETON LANGAS ANAISABEL. Presidente: GONZALEZ VALDERREY IKER. Vicepresid.: BRETON LANGAS ANA ISABEL. Secretario: BRETON LANGASRICARDO. Con.Delegado: GONZALEZ VALDERREY IKER;BRETON LANGAS RICARDO;BRETON LANGAS ANA ISABEL.Modificaciones estatutarias. Modificados en su integridad los estatutos, como consecuencia de su transformaci贸n en SL. Otrosconceptos: Emisi贸n de cuarenta y seis mil cuatrocientas participaciones, n煤meros uno a cuarenta y seis mil cuatrocientos, inclusive,asign谩ndolas a los socios en proporci贸n al valor nominal de las acciones que pose铆an. Datos registrales. T 889 , F 202, S 8, H NA6926, I/A 55 (20.10.23).
09 de Enero de 2023Reelecciones. Auditor: MARTIJA GAMBRA JESUS MARIA. Aud.Supl.: VILLALBA ENVID Y CIA. AUDITORES SL. Datos registrales.T 889 , F 202, S 8, H NA 6926, I/A 54 (29.12.22).
27 de Diciembre de 2021Reelecciones. Auditor: MARTIJA GAMBRA JESUS MARIA. Aud.Supl.: VILLALBA ENVID Y CIA. AUDITORES SL. Datos registrales.T 889 , F 202, S 8, H NA 6926, I/A 53 (17.12.21).
26 de Enero de 2021Ceses/Dimisiones. Aud.Supl.: VILLALBA ENVID Y CIA. AUDITORES SLP. Nombramientos. Aud.Supl.: VILLALBA ENVID Y CIA.AUDITORES SL. Reelecciones. Auditor: MARTIJA GAMBRA JESUS MARIA. Datos registrales. T 889 , F 201, S 8, H NA 6926, I/A51 (18.01.21).
Reelecciones. Auditor: MARTIJA GAMBRA JESUS MARIA. Aud.Supl.: VILLALBA ENVID Y CIA. AUDITORES SL. Datos registrales.T 889 , F 202, S 8, H NA 6926, I/A 52 (18.01.21).
24 de Diciembre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: BRETON LANGAS RICARDO;BRETON SOLA PEDRO MARIA;GONZALEZ VALDERREY IKER.Presidente: BRETON SOLA PEDRO MARIA. Secretario: BRETON LANGAS RICARDO. Vicepresid.: GONZALEZ VALDERREY IKER.Con.Delegado: BRETON SOLA PEDRO MARIA;GONZALEZ VALDERREY IKER;BRETON LANGAS RICARDO. Nombramientos.Consejero: GONZALEZ VALDERREY IKER. Presidente: GONZALEZ VALDERREY IKER. Consejero: BRETON LANGAS RICARDO.Secretario: BRETON LANGAS RICARDO. Consejero: BRETON LANGAS ANA ISABEL. Vicepresid.: BRETON LANGAS ANA ISABEL.Con.Delegado: GONZALEZ VALDERREY IKER;BRETON LANGAS RICARDO;BRETON LANGAS ANA ISABEL. Modificacionesestatutarias. MODIFICADO el art铆culo 15 de los estatutos sociales, relativo al r茅gimen retributivo del 贸rgano de administraci贸n. Datosregistrales. T 889 , F 201, S 8, H NA 6926, I/A 50 (16.12.20).
09 de Diciembre de 2020Fe de erratas: En la inscripci贸n 46陋 la entidad VILLALBA, ENVID Y CIA. AUDITORES SLP fue designada auditora suplente, y noauditora como se public贸 por error. Datos registrales. T 317 , F 65, S 8, H NA 6926, I/A 46 (20.02.17).
25 de Agosto de 2020Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 435.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 696.000,00 Euros. Otros conceptos:RENUMERAR y asignar las acciones existentes tras la reducci贸n de capital de forma correlativa y a partir de la unidad. Datosregistrales. T 889 , F 200, S 8, H NA 6926, I/A 49 (12.08.20).
19 de Junio de 2018Nombramientos. Apoderado: PEREZ DE OBANOS HERNANDEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 317 , F 65, S 8, H NA 6926, I/A48 (31.05.18).
10 de Octubre de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 87.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.131.000,00 Euros. Otros conceptos:RENUMERADAS las acciones resultantes de la reducci贸n de capital y asignarlas a los socios en el mismo n煤mero que les pertenec铆ancon anterioridad. Datos registrales. T 317 , F 65, S 8, H NA 6926, I/A 47 ( 2.10.17).
28 de Febrero de 2017Ceses/Dimisiones. Auditor: LARRA脩ETA ITURRIA IGNACIO. Aud.Supl.: FAGOAGA REKALDE MARTIN JOSE. Nombramientos.Auditor: MARTIJA GAMBRA JESUS MARIA;VILLALBA ENVID Y CIA. AUDITORES SLP. Datos registrales. T 317 , F 65, S 8, H NA6926, I/A 46 (20.02.17).
07 de Febrero de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 522.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.218.000,00 Euros. Otros conceptos:Renumeradas las acciones subsistentes tras la reducci贸n de la 1 a la 81.200, inclusive. Asignada la titularidad de las mismas a losaccionistas. Datos registrales. T 317 , F 64, S 8, H NA 6926, I/A 45 (27.01.17).
15 de Noviembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: HUGUET ARAZURI JAVIER. Vicesecret.: HUGUET ARAZURI JAVIER. Consejero: OLLO ALVAREZJOSE LUIS. Presidente: OLLO ALVAREZ JOSE LUIS. Consejero: GAZTELU SANZ MIGUEL ANGEL. Secretario: GAZTELU SANZMIGUEL ANGEL. Consejero: BRETON SOLA PEDRO MARIA. Vicepresid.: BRETON SOLA PEDRO MARIA. Con.Delegado: GAZTELUSANZ MIGUEL ANGEL;OLLO ALVAREZ JOSE LUIS. Nombramientos. Consejero: BRETON LANGAS RICARDO;BRETON SOLAPEDRO MARIA;GONZALEZ VALDERREY IKER. Presidente: BRETON SOLA PEDRO MARIA. Secretario: BRETON LANGASRICARDO. Vicepresid.: GONZALEZ VALDERREY IKER. Con.Delegado: BRETON SOLA PEDRO MARIA;GONZALEZ VALDERREYIKER;BRETON LANGAS RICARDO. Datos registrales. T 317 , F 64, S 8, H NA 6926, I/A 44 ( 4.11.16).
15 de Julio de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: HUGUET ARAZURI JAVIER;OLLO ALVAREZ JOSE LUIS;BRETON LANGAS RICARDO;BRETONSOLA PEDRO MARIA. Presidente: OLLO ALVAREZ JOSE LUIS. Vicepresid.: BRETON SOLA PEDRO MARIA. Vicesecret.: HUGUETARAZURI JAVIER. Secretario: BRETON LANGAS RICARDO. Con.Delegado: BRETON LANGAS RICARDO;OLLO ALVAREZ JOSELUIS. Nombramientos. Consejero: HUGUET ARAZURI JAVIER. Vicesecret.: HUGUET ARAZURI JAVIER. Consejero: OLLOALVAREZ JOSE LUIS. Presidente: OLLO ALVAREZ JOSE LUIS. Consejero: GAZTELU SANZ MIGUEL ANGEL. Secretario: GAZTELUSANZ MIGUEL ANGEL. Consejero: BRETON SOLA PEDRO MARIA. Vicepresid.: BRETON SOLA PEDRO MARIA. Con.Delegado:GAZTELU SANZ MIGUEL ANGEL;OLLO ALVAREZ JOSE LUIS. Otros conceptos: FIJAR en cuatro el n煤mero de miembros delConsejo de Administraci贸n. RATIFICAR todos los actos realizados en nombre y representaci贸n de la Sociedad por los consejeroscesados. Datos registrales. T 317 , F 64, S 8, H NA 6926, I/A 43 ( 3.07.14).
07 de Enero de 2014Ceses/Dimisiones. Auditor: ZUFIAURRE ALDAZ DE ECHAVACOIZ FRANCISCO JOSE. Aud.Supl.: ECHARRI HERNANDEZJAVIER. Nombramientos. Auditor: LARRA脩ETA ITURRIA IGNACIO. Aud.Supl.: FAGOAGA REKALDE MARTIN JOSE. Datosregistrales. T 317 , F 65, S 8, H NA 6926, I/A 42 (27.12.13).
31 de Enero de 2012Reelecciones. Auditor: ZUFIAURRE ALDAZ DE ECHAVACOIZ FRANCISCO JOSE. Aud.Supl.: ECHARRI HERNANDEZ JAVIER.Datos registrales. T 317 , F 63, S 8, H NA 6926, I/A 41 (17.01.12).
07 de Abril de 2009Ceses/Dimisiones. Auditor Sup.: GOIZUETA ZARAGUETA JESUS. Auditor Titu: ZUFIAURRE ALDAZ DE ECHAVACOIZFRANCISCO JOSE. Nombramientos. Auditor Titu: ZUFIAURRE ALDAZ DE ECHAVACOIZ FRANCISCO JOSE. Auditor Sup.:
17 de Marzo de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: BRETON GO脩I RICARDO. Presidente: BRETON GO脩I RICARDO. Cons.Delegad: BRETON GO脩IRICARDO. Consejero: BRETON SOLA PEDRO MARIA. Vicepresiden: BRETON SOLA PEDRO MARIA. Secretario: OLLO ALVAREZJOSE LUIS. Cons.Delegad: OLLO ALVAREZ JOSE LUIS. Consejero: OLLO ALVAREZ JOSE LUIS;HUGUET ARAZURI JAVIER.Vicesecretar: HUGUET ARAZURI JAVIER. Nombramientos. Consejero: HUGUET ARAZURI JAVIER;OLLO ALVAREZ JOSELUIS;BRETON LANGAS RICARDO;BRETON SOLA PEDRO MARIA. Presidente: OLLO ALVAREZ JOSE LUIS. Vicepresiden:BRETON SOLA PEDRO MARIA. Vicesecretar: HUGUET ARAZURI JAVIER. Secretario: BRETON LANGAS RICARDO. Cons.Delegad:BRETON LANGAS RICARDO;OLLO ALVAREZ JOSE LUIS. Otros conceptos: OTROS ACTOS. Lugar del acuerdo: Huarte-Pamplona. Fecha del acuerdo: 22/12/2008. La junta RATIFICO expresamente todos los actos realizados en nombre de la sociedad porel 贸rgano deadministraci贸n cesado. Datos registrales. T 317 , F 63, S 8, H NA006926, I/A00039 ( 6.03.09).