Buscador CIF Logo

Actos BORME Plasticos Brello Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Plasticos Brello Sa

Actos BORME Plasticos Brello Sa - A31018187

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Navarra para Plasticos Brello Sa con CIF A31018187

馃敊 Perfil de Plasticos Brello Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Navarra

Actos BORME de Plasticos Brello Sa

27 de Octubre de 2023
Transformaci贸n de sociedad. Denominaci贸n y forma adoptada: PLASTICOS BRELLO SL. Ceses/Dimisiones. Vicepresid.:BRETON LANGAS ANA ISABEL. Con.Delegado: BRETON LANGAS ANA ISABEL. Consejero: BRETON LANGAS ANA ISABEL.Secretario: BRETON LANGAS RICARDO. Consejero: BRETON LANGAS RICARDO. Presidente: GONZALEZ VALDERREY IKER.Con.Delegado: GONZALEZ VALDERREY IKER. Consejero: GONZALEZ VALDERREY IKER. Con.Delegado: BRETON LANGASRICARDO. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ VALDERREY IKER;BRETON LANGAS RICARDO;BRETON LANGAS ANAISABEL. Presidente: GONZALEZ VALDERREY IKER. Vicepresid.: BRETON LANGAS ANA ISABEL. Secretario: BRETON LANGASRICARDO. Con.Delegado: GONZALEZ VALDERREY IKER;BRETON LANGAS RICARDO;BRETON LANGAS ANA ISABEL.Modificaciones estatutarias. Modificados en su integridad los estatutos, como consecuencia de su transformaci贸n en SL. Otrosconceptos: Emisi贸n de cuarenta y seis mil cuatrocientas participaciones, n煤meros uno a cuarenta y seis mil cuatrocientos, inclusive,asign谩ndolas a los socios en proporci贸n al valor nominal de las acciones que pose铆an. Datos registrales. T 889 , F 202, S 8, H NA6926, I/A 55 (20.10.23).

09 de Enero de 2023
Reelecciones. Auditor: MARTIJA GAMBRA JESUS MARIA. Aud.Supl.: VILLALBA ENVID Y CIA. AUDITORES SL. Datos registrales.T 889 , F 202, S 8, H NA 6926, I/A 54 (29.12.22).

27 de Diciembre de 2021
Reelecciones. Auditor: MARTIJA GAMBRA JESUS MARIA. Aud.Supl.: VILLALBA ENVID Y CIA. AUDITORES SL. Datos registrales.T 889 , F 202, S 8, H NA 6926, I/A 53 (17.12.21).

26 de Enero de 2021
Ceses/Dimisiones. Aud.Supl.: VILLALBA ENVID Y CIA. AUDITORES SLP. Nombramientos. Aud.Supl.: VILLALBA ENVID Y CIA.AUDITORES SL. Reelecciones. Auditor: MARTIJA GAMBRA JESUS MARIA. Datos registrales. T 889 , F 201, S 8, H NA 6926, I/A51 (18.01.21).

Reelecciones. Auditor: MARTIJA GAMBRA JESUS MARIA. Aud.Supl.: VILLALBA ENVID Y CIA. AUDITORES SL. Datos registrales.T 889 , F 202, S 8, H NA 6926, I/A 52 (18.01.21).

24 de Diciembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: BRETON LANGAS RICARDO;BRETON SOLA PEDRO MARIA;GONZALEZ VALDERREY IKER.Presidente: BRETON SOLA PEDRO MARIA. Secretario: BRETON LANGAS RICARDO. Vicepresid.: GONZALEZ VALDERREY IKER.Con.Delegado: BRETON SOLA PEDRO MARIA;GONZALEZ VALDERREY IKER;BRETON LANGAS RICARDO. Nombramientos.Consejero: GONZALEZ VALDERREY IKER. Presidente: GONZALEZ VALDERREY IKER. Consejero: BRETON LANGAS RICARDO.Secretario: BRETON LANGAS RICARDO. Consejero: BRETON LANGAS ANA ISABEL. Vicepresid.: BRETON LANGAS ANA ISABEL.Con.Delegado: GONZALEZ VALDERREY IKER;BRETON LANGAS RICARDO;BRETON LANGAS ANA ISABEL. Modificacionesestatutarias. MODIFICADO el art铆culo 15 de los estatutos sociales, relativo al r茅gimen retributivo del 贸rgano de administraci贸n. Datosregistrales. T 889 , F 201, S 8, H NA 6926, I/A 50 (16.12.20).

09 de Diciembre de 2020
Fe de erratas: En la inscripci贸n 46陋 la entidad VILLALBA, ENVID Y CIA. AUDITORES SLP fue designada auditora suplente, y noauditora como se public贸 por error. Datos registrales. T 317 , F 65, S 8, H NA 6926, I/A 46 (20.02.17).

25 de Agosto de 2020
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 435.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 696.000,00 Euros. Otros conceptos:RENUMERAR y asignar las acciones existentes tras la reducci贸n de capital de forma correlativa y a partir de la unidad. Datosregistrales. T 889 , F 200, S 8, H NA 6926, I/A 49 (12.08.20).

19 de Junio de 2018
Nombramientos. Apoderado: PEREZ DE OBANOS HERNANDEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 317 , F 65, S 8, H NA 6926, I/A48 (31.05.18).

10 de Octubre de 2017
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 87.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.131.000,00 Euros. Otros conceptos:RENUMERADAS las acciones resultantes de la reducci贸n de capital y asignarlas a los socios en el mismo n煤mero que les pertenec铆ancon anterioridad. Datos registrales. T 317 , F 65, S 8, H NA 6926, I/A 47 ( 2.10.17).

28 de Febrero de 2017
Ceses/Dimisiones. Auditor: LARRA脩ETA ITURRIA IGNACIO. Aud.Supl.: FAGOAGA REKALDE MARTIN JOSE. Nombramientos.Auditor: MARTIJA GAMBRA JESUS MARIA;VILLALBA ENVID Y CIA. AUDITORES SLP. Datos registrales. T 317 , F 65, S 8, H NA6926, I/A 46 (20.02.17).

07 de Febrero de 2017
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 522.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.218.000,00 Euros. Otros conceptos:Renumeradas las acciones subsistentes tras la reducci贸n de la 1 a la 81.200, inclusive. Asignada la titularidad de las mismas a losaccionistas. Datos registrales. T 317 , F 64, S 8, H NA 6926, I/A 45 (27.01.17).

15 de Noviembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: HUGUET ARAZURI JAVIER. Vicesecret.: HUGUET ARAZURI JAVIER. Consejero: OLLO ALVAREZJOSE LUIS. Presidente: OLLO ALVAREZ JOSE LUIS. Consejero: GAZTELU SANZ MIGUEL ANGEL. Secretario: GAZTELU SANZMIGUEL ANGEL. Consejero: BRETON SOLA PEDRO MARIA. Vicepresid.: BRETON SOLA PEDRO MARIA. Con.Delegado: GAZTELUSANZ MIGUEL ANGEL;OLLO ALVAREZ JOSE LUIS. Nombramientos. Consejero: BRETON LANGAS RICARDO;BRETON SOLAPEDRO MARIA;GONZALEZ VALDERREY IKER. Presidente: BRETON SOLA PEDRO MARIA. Secretario: BRETON LANGASRICARDO. Vicepresid.: GONZALEZ VALDERREY IKER. Con.Delegado: BRETON SOLA PEDRO MARIA;GONZALEZ VALDERREYIKER;BRETON LANGAS RICARDO. Datos registrales. T 317 , F 64, S 8, H NA 6926, I/A 44 ( 4.11.16).

15 de Julio de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: HUGUET ARAZURI JAVIER;OLLO ALVAREZ JOSE LUIS;BRETON LANGAS RICARDO;BRETONSOLA PEDRO MARIA. Presidente: OLLO ALVAREZ JOSE LUIS. Vicepresid.: BRETON SOLA PEDRO MARIA. Vicesecret.: HUGUETARAZURI JAVIER. Secretario: BRETON LANGAS RICARDO. Con.Delegado: BRETON LANGAS RICARDO;OLLO ALVAREZ JOSELUIS. Nombramientos. Consejero: HUGUET ARAZURI JAVIER. Vicesecret.: HUGUET ARAZURI JAVIER. Consejero: OLLOALVAREZ JOSE LUIS. Presidente: OLLO ALVAREZ JOSE LUIS. Consejero: GAZTELU SANZ MIGUEL ANGEL. Secretario: GAZTELUSANZ MIGUEL ANGEL. Consejero: BRETON SOLA PEDRO MARIA. Vicepresid.: BRETON SOLA PEDRO MARIA. Con.Delegado:GAZTELU SANZ MIGUEL ANGEL;OLLO ALVAREZ JOSE LUIS. Otros conceptos: FIJAR en cuatro el n煤mero de miembros delConsejo de Administraci贸n. RATIFICAR todos los actos realizados en nombre y representaci贸n de la Sociedad por los consejeroscesados. Datos registrales. T 317 , F 64, S 8, H NA 6926, I/A 43 ( 3.07.14).

07 de Enero de 2014
Ceses/Dimisiones. Auditor: ZUFIAURRE ALDAZ DE ECHAVACOIZ FRANCISCO JOSE. Aud.Supl.: ECHARRI HERNANDEZJAVIER. Nombramientos. Auditor: LARRA脩ETA ITURRIA IGNACIO. Aud.Supl.: FAGOAGA REKALDE MARTIN JOSE. Datosregistrales. T 317 , F 65, S 8, H NA 6926, I/A 42 (27.12.13).

31 de Enero de 2012
Reelecciones. Auditor: ZUFIAURRE ALDAZ DE ECHAVACOIZ FRANCISCO JOSE. Aud.Supl.: ECHARRI HERNANDEZ JAVIER.Datos registrales. T 317 , F 63, S 8, H NA 6926, I/A 41 (17.01.12).

07 de Abril de 2009
Ceses/Dimisiones. Auditor Sup.: GOIZUETA ZARAGUETA JESUS. Auditor Titu: ZUFIAURRE ALDAZ DE ECHAVACOIZFRANCISCO JOSE. Nombramientos. Auditor Titu: ZUFIAURRE ALDAZ DE ECHAVACOIZ FRANCISCO JOSE. Auditor Sup.:

17 de Marzo de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: BRETON GO脩I RICARDO. Presidente: BRETON GO脩I RICARDO. Cons.Delegad: BRETON GO脩IRICARDO. Consejero: BRETON SOLA PEDRO MARIA. Vicepresiden: BRETON SOLA PEDRO MARIA. Secretario: OLLO ALVAREZJOSE LUIS. Cons.Delegad: OLLO ALVAREZ JOSE LUIS. Consejero: OLLO ALVAREZ JOSE LUIS;HUGUET ARAZURI JAVIER.Vicesecretar: HUGUET ARAZURI JAVIER. Nombramientos. Consejero: HUGUET ARAZURI JAVIER;OLLO ALVAREZ JOSELUIS;BRETON LANGAS RICARDO;BRETON SOLA PEDRO MARIA. Presidente: OLLO ALVAREZ JOSE LUIS. Vicepresiden:BRETON SOLA PEDRO MARIA. Vicesecretar: HUGUET ARAZURI JAVIER. Secretario: BRETON LANGAS RICARDO. Cons.Delegad:BRETON LANGAS RICARDO;OLLO ALVAREZ JOSE LUIS. Otros conceptos: OTROS ACTOS. Lugar del acuerdo: Huarte-Pamplona. Fecha del acuerdo: 22/12/2008. La junta RATIFICO expresamente todos los actos realizados en nombre de la sociedad porel 贸rgano deadministraci贸n cesado. Datos registrales. T 317 , F 63, S 8, H NA006926, I/A00039 ( 6.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n