Buscador CIF Logo

Actos BORME Plastipak Iberia Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Plastipak Iberia Sl

Actos BORME Plastipak Iberia Sl - B66460775

Tenemos registrados 24 Actos BORME del Registro Mercantil de Toledo para Plastipak Iberia Sl con CIF B66460775

馃敊 Perfil de Plastipak Iberia Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Toledo

Actos BORME de Plastipak Iberia Sl

03 de Noviembre de 2023
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 1757 , F 215, S 8, H TO 37456, I/A 24 (26.10.23).

11 de Mayo de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDO MARTIN LEON;VICENTE MONTOJO COLL. Datos registrales. T 1757 , F 215, S 8, H TO37456, I/A 22 ( 3.05.23).

17 de Abril de 2023
Revocaciones. Apo.Manc.: FRANCIS D. POLLOCK;MICHAEL J PLOTZKE;WILLIAM CARL YOUNG. Apo.Sol.: FERNANDO MARTINLEON. Apo.Manc.: FERNANDO MARTIN LEON. Datos registrales. T 1738 , F 170, S 8, H TO 37456, I/A 19 ( 3.04.23).

Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDO MARTIN LEON;MARIA ANGELES PRIETO PEREZ;MICHAEL JOSEPH PLOTZKE;WILLIAMCARL YOUNG. Apo.Manc.: FERNANDO MARTIN LEON;MARIA ANGELES PRIETO PEREZ;IVO WEITOSCH;CRISTOPHER JOHNZIMMER. Datos registrales. T 1738 , F 170, S 8, H TO 37456, I/A 20 ( 3.04.23).

Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDO MARTIN LEON. Apo.Manc.: FERNANDO MARTIN LEON. Apo.Sol.: VICENTE MONTOJOCOLL. Apo.Manc.: VICENTE MONTOJO COLL;WILLIAM CARL YOUNG;MICHAEL JOSEPH PLOTZKE;MATTHEW GERARD FRANZ.Datos registrales. T 1738 , F 171, S 8, H TO 37456, I/A 21 ( 3.04.23).

13 de Octubre de 2022
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 1738 , F 170, S 8, H TO 37456, I/A 18 ( 6.10.22).

21 de Abril de 2022
Nombramientos. VsecrNoConsj: KOLISNYCHENKO OGREBCHUK SVITLANA. Datos registrales. T 1698 , F 217, S 8, H TO37456, I/A 16 ( 7.04.22).

Nombramientos. Apo.Sol.: MONTOJO COLL VICENTE;HEINRICH CLAIRE GERMAINE MARIENE. Datos registrales. T 1698 , F217, S 8, H TO 37456, I/A 17 ( 7.04.22).

09 de Diciembre de 2021
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 1698 , F 217, S 8, H TO 37456, I/A 15 (30.11.21).

07 de Mayo de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: POLLOCK FRANCIS DENNIS. Nombramientos. Consejero: GERARD FRANZ MATTHEW. Datosregistrales. T 1698 , F 217, S 8, H TO 37456, I/A 14 (29.04.21).

17 de Noviembre de 2020
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 1698 , F 216, S 8, H TO 37456, I/A 13 ( 9.11.20).

17 de Septiembre de 2020
Revocaciones. Apo.Manc.: TORRES PRADA JOSE-ANTONIO. Apo.Sol.: TORRES PRADA JOSE-ANTONIO. Datos registrales. T1698 , F 216, S 8, H TO 37456, I/A 12 ( 9.09.20).

30 de Marzo de 2020
Nombramientos. Apoderado: LEON MARTIN FERNANDO;PRIETO PEREZ MARIA ANGELES;COTON REMON MIGUELANGEL;GIACOBONE RAYMOND RUDOLPHO;ZIMMER CRISTOPHER JOHN;WEITOSCH IVO. Datos registrales. T 1698 , F 216, S8, H TO 37456, I/A 11 (20.03.20).

25 de Marzo de 2020
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 1698 , F 216, S 8, H TO 37456, I/A 10 (11.03.20).

09 de Marzo de 2020
Otros conceptos: Resoluci贸n Individual de concesi贸n de Incentivos Regionales de fecha 27 de Noviembre de 2019, expedienteTO/798/P03. Aceptados en fecha 3 de enero de 2020 por importe de 1.633.357,04 euros. Datos registrales. T 1698 , F 216, S 8, HTO 37456, I/AMargi ( 2.03.20).

26 de Febrero de 2020
Revocaciones. Apo.Manc.: HARGREAVES MARTIN LAWRENCE. Apo.Sol.: ONTIVEROS NIETO NATALIA;COLDECARRERA VEGAALBERT. Datos registrales. T 1698 , F 216, S 8, H TO 37456, I/A 9 (19.02.20).

11 de Diciembre de 2018
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: BRIZ PUERTAS MARIA DE LAS NIEVES. Datos registrales. T 1609 , F 15, S 8, H TO 37456, I/A8 ( 3.12.18).

18 de Junio de 2018
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 1609 , F 15, S 8, H TO 37456, I/A 7 ( 7.06.18).

08 de Agosto de 2016
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BOU MAQUEDA AGUSTI. Nombramientos. Consejero: YOUNG WILLIAM CARL;PLOTZKEMICHAEL JOSEPH;POLLOCK FRANCIS DENNIS. Presidente: YOUNG WILLIAM CARL. Con.Delegado: YOUNG WILLIAM CARL.SecreNoConsj: BOU MAQUEDA AGUSTI. Apo.Sol.: ONTIVEROS NIETO NATALIA;COLDECARRERA VEGA ALBERT. VsecrNoConsj:BRIZ PUERTAS MARIA DE LAS NIEVES. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejode administraci贸n. Datos registrales. T 1609 , F 15, S 8, H TO 37456, I/A 6 ( 1.08.16).

19 de Noviembre de 2015
Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.646.994,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.650.000,00 Euros. Datos registrales. T 1609 , F 14, S 8,H TO 37456, I/A 4 (12.11.15).

06 de Agosto de 2015
Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 1609 , F 14, S 8, H TO 37456, I/A 3 (30.07.15).

10 de Julio de 2015
Cambio de domicilio social. AVDA DE LA CONSTITUCION S/N (CASARRUBIOS DEL MONTE). Datos registrales. T 1609 , F 14,S 8, H TO 37456, I/A 2 (30.06.15).

03 de Julio de 2015
Modificaciones estatutarias. ART. 5 : FIJACION DE LA FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, FINALIZANDO EL 31 DEOCTUBRE DE CADA A脩O. Datos registrales. T 44659 , F 42, S 8, H B 462686, I/A 5 (25.06.15).

29 de Junio de 2015
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: TORRES PRADA JOSE ANTONIO;MARTIN LEON FERNANDO. APOD.MANCOMU: WILLIAMCARL YOUNG;MICHAEL J PLOTZKE;FRANCIS D POLLOCK;MARTIN LAWRENCE HARGREAVES. Datos registrales. T 44659 , F40, S 8, H B 462686, I/A 4 (23.06.15).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n