Actos BORME de Plhus Plataforma Logistica Sociedad Limitada
20 de Septiembre de 2018Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: ARIZNAVARRETA TEJEDOR MARTA. SecreNoConsj: CABEZA MURILLO CLAUDIA. L. Asesor:BIENDICHO GRACIA LUIS. Consejero: OLIVAN BELLOSTA GERARDO;GASTON MENAL MARTA;LANASPA SANTOLARIA LUISFERNANDO;FORNALS ENGUIDANOS MARIA DOLORES;MARTIN EXPOSITO JUAN;FELIPE SERRATE LUIS. Presidente: GASTONMENAL MARTA. Consejero: CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON SOCIEDAD. Revocaciones. Apoderado: DELA FUENTE GOMEZ FRANCISCO;LOSTAO GARCIA BELEN. Apo.Sol.: DE LA FUENTE GOMEZ FRANCISCO;LANASPASANTOLARIA LUIS FERNANDO. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 4078 , F 58, S 8, H Z 41811, I/A 40(13.09.18).
18 de Abril de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ CUELLO FERNANDO. Nombramientos. Consejero: CORPORACION EMPRESARIALPUBLICA DE ARAGON SOCIEDAD. Datos registrales. T 4078 , F 58, S 8, H Z 41811, I/A 39 (11.04.18).
12 de Febrero de 2018Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON SOCIEDAD. Reducci贸nde capital. Importe reducci贸n: 4.487.057,54 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital: 750.000,00Euros. Resultante Suscrito: 750.000,00 Euros. Datos registrales. T 4078 , F 57, S 8, H Z 41811, I/A 38 ( 6.02.18).
27 de Diciembre de 2017Nombramientos. Aud.Manc: CGM AUDITORES SL. Reelecciones. Aud.Manc: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SOCIEDADLIMITADA P. Datos registrales. T 4078 , F 57, S 8, H Z 41811, I/A 37 (19.12.17).
26 de Mayo de 2017Cambio de domicilio social. PASEO M陋 AGUSTIN, 36 (ZARAGOZA). Datos registrales. T 4078 , F 57, S 8, H Z 41811, I/A 36(19.05.17).
25 de Mayo de 2017Revocaciones. Apoderado: LOSTAO GARCIA BELEN. Nombramientos. Apoderado: LOSTAO GARCIA BELEN. Apo.Sol.: DE LAFUENTE GOMEZ FRANCISCO;LANASPA SANTOLARIA LUIS FERNANDO. Datos registrales. T 4078 , F 55, S 8, H Z 41811, I/A 35(15.05.17).
25 de Enero de 2017Reelecciones. Aud.Manc: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA P;PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 4078 , F 55, S 8, H Z 41811, I/A 34 (17.01.17).
03 de Enero de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 11.948.230,14 Euros. Resultante Suscrito: 2.987.057,54 Euros. Ampliaci贸n de capital.Capital: 1.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.487.057,54 Euros. Datos registrales. T 4078 , F 55, S 8, H Z 41811, I/A 33(23.12.16).
12 de Julio de 2016Nombramientos. L. Asesor: BIENDICHO GRACIA LUIS. Datos registrales. T 4078 , F 55, S 8, H Z 41811, I/A 32 ( 4.07.16).
28 de Junio de 2016Nombramientos. Apoderado: LOSTAO GARCIA BELEN. Datos registrales. T 4078 , F 54, S 8, H Z 41811, I/A 31 (20.06.16).
14 de Junio de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: ALOS LOPEZ ANA;LAFUENTE ASO FERNANDO. Datos registrales. T 4078 , F 53, S 8, H Z 41811,I/A 29 ( 3.06.16).
Revocaciones. Apo.Sol.: LAHOZ PENON RAQUEL;DIEZ GRIJALBO SAMUEL;GARCIA FIGUERAS MANUEL;ARTAZOS HERCEISABEL;RISUE脩O VILLANUEVA BELEN;LAGUARTA RECAJ MARIANO;BONILLA SAURAS MANUEL. Apoderado: FRANCHBARRABES JOSE MARIA. Apo.Man.Soli: TESA AVILLA MANUEL. Nombramientos. VsecrNoConsj: ARIZNAVARRETA TEJEDORMARTA. Datos registrales. T 4078 , F 53, S 8, H Z 41811, I/A 30 ( 3.06.16).
01 de Marzo de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ DE ALARCON HERRERO RAFAEL. Presidente: FERNANDEZ DE ALARCONHERRERO RAFAEL. Consejero: CASABONA BERBERANA MARIA-ASUNCION;ANDREU MERELLES JESUS;TARDOS SOLANOJOSE-MARIA;VALDIVIA LOPEZ PILAR. Nombramientos. Consejero: GASTON MENAL MARTA;LANASPA SANTOLARIA LUISFERNANDO;FERNANDEZ CUELLO FERNANDO;FORNALS ENGUIDANOS MARIA DOLORES;MARTIN EXPOSITO JUAN;FELIPESERRATE LUIS. Presidente: GASTON MENAL MARTA. Datos registrales. T 4078 , F 51, S 8, H Z 41811, I/A 24 (22.02.16).
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: PONCE MARTINEZ MARIA JOSE. Nombramientos. SecreNoConsj: CABEZA MURILLOCLAUDIA. Datos registrales. T 4078 , F 51, S 8, H Z 41811, I/A 25 (23.02.16).
Nombramientos. Aud.Manc: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA P;PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 4078 , F 51, S 8, H Z 41811, I/A 26 (22.02.16).
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ DE ALARCON HERRERO RAFAEL. Apo.Manc.: ANDREU MERELLES JESUS-FERNANDO. Nombramientos. Apoderado: DE LA FUENTE GOMEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 4078 , F 52, S 8, H Z41811, I/A 27 (22.02.16).
Nombramientos. Consejero: OLIVAN BELLOSTA GERARDO. Datos registrales. T 4078 , F 53, S 8, H Z 41811, I/A 28 (22.02.16).
30 de Julio de 2015Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 8.401.099,32 Euros. Resultante Suscrito: 14.935.287,68 Euros. Datos registrales. T 4078, F 51, S 8, H Z 41811, I/A 23 (23.07.15).
07 de Enero de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.200.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 23.336.387,00 Euros. Datos registrales. T 3798 , F 178, S8, H Z 41811, I/A 22 (24.12.14).
01 de Septiembre de 2014Reelecciones. Aud.Manc: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA P;PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 3798 , F 178, S 8, H Z 41811, I/A 21 (21.08.14).
23 de Diciembre de 2013Ampliaci贸n de capital. Capital: 4.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 21.136.387,00 Euros. Datos registrales. T 3798 , F 178, S8, H Z 41811, I/A 20 (11.12.13).
08 de Noviembre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA ALDEA JOSE-LEON. Nombramientos. Consejero: VALDIVIA LOPEZ PILAR. Datosregistrales. T 3798 , F 178, S 8, H Z 41811, I/A 19 (30.10.13).
01 de Junio de 2012Nombramientos. Apo.Manc.: ANDREU MERELLES JESUS-FERNANDO. Otros conceptos: Modificado el poder objeto de lainscripci贸n 10&, en cuantoa Don Manuel Tesa Avilla, por la 18&.Modificado el poder objeto de la inscripci贸n 17&, en cuantoa DonRafael Fern谩ndez de Alarc贸n, por la 18&. Datos registrales. T 3798 , F 177, S 8, H Z 41811, I/A 18 (22.05.12).
02 de Marzo de 2012Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: FAUQUIE BORRAJO DAVID. Nombramientos. SecreNoConsj: PONCE MARTINEZ MARIAJOSE. Datos registrales. T 3798 , F 174, S 8, H Z 41811, I/A 13 (20.02.12).
Ceses/Dimisiones. Consejero: VICENTE BARRA ALFONSO. Presidente: VICENTE BARRA ALFONSO. Consejero: VAZQUEZLOPEZ RAFAEL;TESA AVILLA MANUEL;AYUNTAMIENTO DE HUESCA;GARETA NAVARRO GEMA. Nombramientos. Consejero:FERNANDEZ DE ALARCON HERRERO RAFAEL. Presidente: FERNANDEZ DE ALARCON HERRERO RAFAEL. Consejero: ALOSLOPEZ ANA;GARCIA ALDEA JOSE-LEON;CASABONA BERBERANA MARIA-ASUNCION;ANDREU MERELLES JESUS;TARDOSSOLANO JOSE-MARIA;LAFUENTE ASO FERNANDO. Datos registrales. T 3798 , F 174, S 8, H Z 41811, I/A 14 (20.02.12).
Nombramientos. Aud.Manc: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL;VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SOCIEDADLIMITADA P. Datos registrales. T 3798 , F 174, S 8, H Z 41811, I/A 15 (20.02.12).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: VICENTE BARRA ALFONSO. Apo.Sol.: FAUQUIE BORRAJO DAVID. Datos registrales. T 3798 , F176, S 8, H Z 41811, I/A 16 (20.02.12).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ DE ALARCON HERRERO RAFAEL. Datos registrales. T 3798 , F 176, S 8, H Z 41811,I/A 17 (20.02.12).
03 de Agosto de 2011Cambio de domicilio social. AVDA DIAGONAL 30 - PLAZA DE LA PLATAFORMA LOGISTIC (ZARAGOZA). Datos registrales. T3798 , F 174, S 8, H Z 41811, I/A 12 (21.07.11).
25 de Enero de 2011Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3798 , F 174, S 8, H Z 41811, I/A 11 (12.01.11).
17 de Septiembre de 2010Revocaciones. Apo.Man.Soli: TESA AVILLA MANUEL. Apoderado: VICENTE BARRA ALFONSO. Nombramientos. Apo.Man.Soli:VICENTE BARRA ALFONSO;TESA AVILLA MANUEL. Datos registrales. T 3422 , F 81, S 8, H Z 41811, I/A 10 ( 8.09.10).
07 de Abril de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: ESCO SAMPERIZ CARLOS. Con.Delegado: ESCO SAMPERIZ CARLOS. Datos registrales. T 3422, F 80, S 8, H Z 41811, I/A 9 (25.03.10).
10 de Febrero de 2010Nombramientos. Apoderado: FRANCH BARRABES JOSE MARIA. Datos registrales. T 3422 , F 80, S 8, H Z 41811, I/A 8 (1.02.10).
09 de Diciembre de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 6.347.438,00 Euros. Resultante Suscrito: 16.636.387,00 Euros. Datos registrales. T 3422 , F 78, S8, H Z 41811, I/A 7 (26.11.09).