Buscador CIF Logo

Actos BORME Pm Print Exclusivas De Publicidad Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Pm Print Exclusivas De Publicidad Sl

Actos BORME Pm Print Exclusivas De Publicidad Sl - B86090792

Tenemos registrados 20 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Pm Print Exclusivas De Publicidad Sl con CIF B86090792

馃敊 Perfil de Pm Print Exclusivas De Publicidad Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Pm Print Exclusivas De Publicidad Sl

06 de Noviembre de 2023
Reelecciones. Auditor: FIDELIS CENSEA AUDITORES SL. Datos registrales. T 35271 , F 104, S 8, H M 512389, I/A 20 (27.10.23).

05 de Diciembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PROMEDIOS EUROPEAN GROUP SL. Representan: RAMOS FERNANDEZ MARIA ELENA.Nombramientos. Representan: HERNANDEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL;RAMOS FERNANDEZ MARIA ELENA. Adm. Solid.:GEPEX SL;A P M MEDIA CONSULTING SL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aAdministradores solidarios. Datos registrales. T 35271 , F 103, S 8, H M 512389, I/A 19 (28.11.22).

13 de Octubre de 2022
P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: https://promedios.es. Datos registrales. T 35271 , F 103, S 8, HM 512389, I/A 18 ( 5.10.22).

04 de Mayo de 2022
Modificaciones estatutarias. 11. Modificaci贸n del art铆culo 11 de los estatutos. . Cambio de domicilio social. AVDA SOMOSIERRA12 - NAVE 42 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES). Datos registrales. T 35271 , F 103, S 8, H M 512389, I/A 17 (26.04.22).

08 de Octubre de 2020
Reelecciones. Auditor: FIDELIS CENSEA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 35271 , F 103, S 8, H M 512389, I/A 16 ( 1.10.20).

19 de Marzo de 2019
Revocaciones. Apoderado: OLAZABAL PUIG VICTOR. Datos registrales. T 35271 , F 102, S 8, H M 512389, I/A 15 (12.03.19).

07 de Noviembre de 2017
Reelecciones. Auditor: FIDELIS CENSEA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 35271 , F 102, S 8, H M 512389, I/A 14(30.10.17).

27 de Abril de 2017
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: PROMEDIOS EUROPEAN GROUP SL. Datos registrales. T 35271 , F 102, S 8, HM 512389, I/A 13 (20.04.17).

27 de Marzo de 2017
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ TULLA CARLOS. Datos registrales. T 35271 , F 101, S 8, H M 512389, I/A 12 (16.03.17).

28 de Febrero de 2017
Ceses/Dimisiones. Representan: OLAZABAL PUIG VICTOR. Consejero: CINATOR SL;FALCON EMPRESARIAL SL;EQUIPO

Nombramientos. Apoderado: OLAZABAL PUIG VICTOR. Datos registrales. T 28458 , F 16, S 8, H M 512389, I/A 9 (21.02.17).

Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 28458 , F 17, S 8, H M 512389, I/A10 (21.02.17).

Nombramientos. Apoderado: RAMOS FERNANDEZ MARIA ELENA. Datos registrales. T 28458 , F 18, S 8, H M 512389, I/A 11(21.02.17).

29 de Agosto de 2016
Otros conceptos: Se hace constar el cambio denominaci贸n del auditor por transformaci贸n de sociedad civil a sociedad limitadaprofesional. Datos registrales. T 28458 , F 15, S 8, H M 512389, I/A 7 (22.08.16).

27 de Abril de 2015
Cambio de domicilio social. C/ ROTTERDAM NUMERO 3, POLIGONO EUROPOLIS (ROZAS DE MADRID (LAS)). Datosregistrales. T 28458 , F 15, S 8, H M 512389, I/A 6 (17.04.15).

03 de Diciembre de 2014
Reelecciones. Auditor: AUDIFISA AUDITORES Y CONSULTORES SC. Datos registrales. T 28458 , F 14, S 8, H M 512389, I/A 5(25.11.14).

25 de Octubre de 2012
Modificaciones estatutarias. INTRODUCCION DEL TITULO VII "CUENTAS ANUALES" Y DEL ARTICULO31潞 DE LOSESTATUTOS.. Datos registrales. T 28458 , F 14, S 8, H M 512389, I/A 4 (16.10.12).

30 de Agosto de 2011
Nombramientos. Auditor: AUDIFISA AUDITORES Y CONSULTORES SC. Datos registrales. T 28458 , F 14, S 8, H M 512389, I/A 3(19.08.11).

04 de Febrero de 2011
Nombramientos. Cons.Del.Sol: EQUIPO PARTNER SL;CINATOR SL;FALCON EMPRESARIAL SL. Presidente: EQUIPO PARTNERSL. Secretario: CINATOR SL. Datos registrales. T 28458 , F 12, S 8, H M 512389, I/A 2 (25.01.11).

02 de Febrero de 2011
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 23.11.10. Objeto social: LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE IMPRESION GRAFICAEN GENERAL, QUE INCLUYE, A TITULO ENUNCIATIVO NO LIMITATIVO, LA IMPRESION DE TODO TIPO DE MATERIALPARASOPORTES DE PUBLICIDAD EXTERIOR, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SOPORTES FISICOS. Domicilio: C/ MAR DEJAVA 3 (MAJADAHONDA). Capital: 60.500,00 Euros. Nombramientos. Representan: OLAZABAL PUIG VICTOR;RAMOSFERNANDEZ MARIA ELENA;HERNANDEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. Consejero: CINATOR SL;FALCON EMPRESARIALSL;EQUIPO PARTNER SL. Datos registrales. T 28458 , F 1, S 8, H M 512389, I/A 1 (21.01.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n