Actos BORME de Pm Print Exclusivas De Publicidad Sl
06 de Noviembre de 2023Reelecciones. Auditor: FIDELIS CENSEA AUDITORES SL. Datos registrales. T 35271 , F 104, S 8, H M 512389, I/A 20 (27.10.23).
05 de Diciembre de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PROMEDIOS EUROPEAN GROUP SL. Representan: RAMOS FERNANDEZ MARIA ELENA.Nombramientos. Representan: HERNANDEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL;RAMOS FERNANDEZ MARIA ELENA. Adm. Solid.:GEPEX SL;A P M MEDIA CONSULTING SL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aAdministradores solidarios. Datos registrales. T 35271 , F 103, S 8, H M 512389, I/A 19 (28.11.22).
13 de Octubre de 2022P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: https://promedios.es. Datos registrales. T 35271 , F 103, S 8, HM 512389, I/A 18 ( 5.10.22).
04 de Mayo de 2022Modificaciones estatutarias. 11. Modificaci贸n del art铆culo 11 de los estatutos. . Cambio de domicilio social. AVDA SOMOSIERRA12 - NAVE 42 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES). Datos registrales. T 35271 , F 103, S 8, H M 512389, I/A 17 (26.04.22).
08 de Octubre de 2020Reelecciones. Auditor: FIDELIS CENSEA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 35271 , F 103, S 8, H M 512389, I/A 16 ( 1.10.20).
19 de Marzo de 2019Revocaciones. Apoderado: OLAZABAL PUIG VICTOR. Datos registrales. T 35271 , F 102, S 8, H M 512389, I/A 15 (12.03.19).
07 de Noviembre de 2017Reelecciones. Auditor: FIDELIS CENSEA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 35271 , F 102, S 8, H M 512389, I/A 14(30.10.17).
27 de Abril de 2017Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: PROMEDIOS EUROPEAN GROUP SL. Datos registrales. T 35271 , F 102, S 8, HM 512389, I/A 13 (20.04.17).
27 de Marzo de 2017Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ TULLA CARLOS. Datos registrales. T 35271 , F 101, S 8, H M 512389, I/A 12 (16.03.17).
28 de Febrero de 2017Ceses/Dimisiones. Representan: OLAZABAL PUIG VICTOR. Consejero: CINATOR SL;FALCON EMPRESARIAL SL;EQUIPO
Nombramientos. Apoderado: OLAZABAL PUIG VICTOR. Datos registrales. T 28458 , F 16, S 8, H M 512389, I/A 9 (21.02.17).
Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 28458 , F 17, S 8, H M 512389, I/A10 (21.02.17).
Nombramientos. Apoderado: RAMOS FERNANDEZ MARIA ELENA. Datos registrales. T 28458 , F 18, S 8, H M 512389, I/A 11(21.02.17).
29 de Agosto de 2016Otros conceptos: Se hace constar el cambio denominaci贸n del auditor por transformaci贸n de sociedad civil a sociedad limitadaprofesional. Datos registrales. T 28458 , F 15, S 8, H M 512389, I/A 7 (22.08.16).
27 de Abril de 2015Cambio de domicilio social. C/ ROTTERDAM NUMERO 3, POLIGONO EUROPOLIS (ROZAS DE MADRID (LAS)). Datosregistrales. T 28458 , F 15, S 8, H M 512389, I/A 6 (17.04.15).
03 de Diciembre de 2014Reelecciones. Auditor: AUDIFISA AUDITORES Y CONSULTORES SC. Datos registrales. T 28458 , F 14, S 8, H M 512389, I/A 5(25.11.14).
25 de Octubre de 2012Modificaciones estatutarias. INTRODUCCION DEL TITULO VII "CUENTAS ANUALES" Y DEL ARTICULO31潞 DE LOSESTATUTOS.. Datos registrales. T 28458 , F 14, S 8, H M 512389, I/A 4 (16.10.12).
30 de Agosto de 2011Nombramientos. Auditor: AUDIFISA AUDITORES Y CONSULTORES SC. Datos registrales. T 28458 , F 14, S 8, H M 512389, I/A 3(19.08.11).
04 de Febrero de 2011Nombramientos. Cons.Del.Sol: EQUIPO PARTNER SL;CINATOR SL;FALCON EMPRESARIAL SL. Presidente: EQUIPO PARTNERSL. Secretario: CINATOR SL. Datos registrales. T 28458 , F 12, S 8, H M 512389, I/A 2 (25.01.11).
02 de Febrero de 2011Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 23.11.10. Objeto social: LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE IMPRESION GRAFICAEN GENERAL, QUE INCLUYE, A TITULO ENUNCIATIVO NO LIMITATIVO, LA IMPRESION DE TODO TIPO DE MATERIALPARASOPORTES DE PUBLICIDAD EXTERIOR, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SOPORTES FISICOS. Domicilio: C/ MAR DEJAVA 3 (MAJADAHONDA). Capital: 60.500,00 Euros. Nombramientos. Representan: OLAZABAL PUIG VICTOR;RAMOSFERNANDEZ MARIA ELENA;HERNANDEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. Consejero: CINATOR SL;FALCON EMPRESARIALSL;EQUIPO PARTNER SL. Datos registrales. T 28458 , F 1, S 8, H M 512389, I/A 1 (21.01.11).