Actos BORME de Pmg Polmetasa SA
22 de Junio de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: STORM SVEN CARSTEN. Presidente: GUTES SERRA MARIO. Nombramientos. Consejero:ERFURTH FRIEDRICH HEINZ HEINRICH. Presidente: ERFURTH FRIEDRICH HEINZ HEINRICH. Apo.Manc.: ERFURTH FRIEDRICHHEINZ HEINRICH. Reelecciones. Consejero: GUTES SERRA MARIO. Datos registrales. T 3099 , F 106, S 8, H SS 1692, I/A 137(14.06.23).
26 de Enero de 2023Reelecciones. Auditor: RODL & PARTNER AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1919 , F 163, S 8, H SS 1692, I/A 136(13.01.23).
12 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: MIRANDA AMORIN JOSE. Datos registrales. T 1919 , F 162, S 8, H SS 1692, I/A 135 (24.11.22).
05 de Marzo de 2020Nombramientos. Auditor: RODL & PARTNER AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1919 , F 159, S 8, H SS 1692, I/A 131(26.02.20).
26 de Septiembre de 2019Nombramientos. Apo.Manc.: UNAMUNO AYASTUY AINHOA. Datos registrales. T 1919 , F 158, S 8, H SS 1692, I/A 130(16.09.19).
23 de Mayo de 2019Ceses/Dimisiones. Secretario: ARANA KNIRSCH SILVESTRE-PEDRO. Nombramientos. Secretario: GONZALEZ FERNANDEZNAVAMUEL RICARDO. Vicesecret.: AGUDIN CAMPOS JOSE ANTONIO. Apo.Sol.: ARANA KNIRSCH SILVESTRE-PEDRO;VALLEDE ALVEAR ALVARO;BOCOS MARTIN TERESA;AMILLO TORRANO BEATRIZ;SIMON MONTELONGO JOSE MANUEL;ABALCAAMAÑO ALEJANDRA;DIAZ TORTAJADA ALVARO. Datos registrales. T 1919 , F 158, S 8, H SS 1692, I/A 129 (14.05.19).
29 de Marzo de 2019Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1919 , F 158, S 8, H SS 1692, I/A 128 ( 8.03.19).
03 de Abril de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: MEHLMANN ULRICH WERNER;ALJAURE SL. Presidente: MEHLMANN ULRICH WERNER.Revocaciones. Apo.Manc.: MEHLMANN ULRICH WERNER. Apo.Sol.: MEHLMANN ULRICH WERNER. Apo.Manc.: HERASBUZARCO PABLO. Nombramientos. Consejero: GUTES SERRA MARIO. Apo.Manc.: HERAS BUZARCO PABLO. Presidente:GUTES SERRA MARIO. Apo.Manc.: GUTES SERRA MARIO;GONZALEZ FERNANDEZ-NAVAMUEL RICARDO. Apo.Sol.: GUTESSERRA MARIO. Datos registrales. T 1919 , F 30, S 8, H SS 1692, I/A 126 (20.03.18).
01 de Marzo de 2018Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1919 , F 30, S 8, H SS 1692, I/A 125 (19.02.18).
03 de Mayo de 2016Nombramientos. Consejero: WAGNER THOMAS ROLF. Datos registrales. T 1919 , F 30, S 8, H SS 1692, I/A 124 (20.04.16).
03 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA VAZQUEZ JUAN-MIGUEL. Nombramientos. Consejero: KROEKER GOTTFRIEDMICHAEL. Datos registrales. T 1919 , F 28, S 8, H SS 1692, I/A 121 (24.11.15).
22 de Febrero de 2013Revocaciones. Apo.Man.Soli: IMATZ VIZCARRA ANTONIO. Nombramientos. Apo.Manc.: PEREZ GONZALEZGUILLERMO;PEREZ GONZALEZ GUILLERMO. Apo.Sol.: CABO GARCIA SUSANA. Datos registrales. T 1919 , F 27, S 8, H SS1692, I/A 117 (14.02.13).
31 de Agosto de 2012Reelecciones. Consejero: KREHL JURGEN MICHAEL. Presidente: KREHL JURGEN MICHAEL. Datos registrales. T 1919 , F 24, S8, H SS 1692, I/A 115 (22.08.12).
Otros conceptos: PARA ADECUACION DE ESTATUTOS A LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, SE MODIFICA LOS ARTICULOS1,7,8,9,12,13,14,15,19,20,24,25 Y 26. Inclusión nuevo artículo 15 BIS Y MODIFICACION DEL 22. Datos registrales. T 1919 , F 24, S8, H SS 1692, I/A 116 (22.08.12).
11 de Abril de 2012Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: PMG HOLDING GMBH. Datos registrales. T 1919 , F 23, S 8, H SS1692, I/A 112 (28.03.12).
Otros conceptos: Modificación del ARTICULO 6º de los Estatutos Sociales en cuanto a los derechos de los socios. Datosregistrales. T 1919 , F 23, S 8, H SS 1692, I/A 113 (28.03.12).