Actos BORME de Policlinico San Carlos Sl
21 de Diciembre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: IVORRA MIRALLES FRANCISCO;LORENZO SAEZ DIEGO;CABALLERO CABALLERO MARIANO.Presidente: IVORRA MIRALLES FRANCISCO. Vicepresid.: LORENZO SAEZ DIEGO. Secretario: CABALLERO CABALLEROMARIANO. Consejero: NAVARRO RIBERO RICARDO. Co.De.Ma.So: NAVARRO RIBERO RICARDO. Cons.Del.Man: IVORRAMIRALLES FRANCISCO. Extinci贸n. Datos registrales. T 3945 , F 67, S 8, H A 13693, I/A 38 (10.12.20).
22 de Diciembre de 2016Escisi贸n total. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: HOSPITAL SAN CARLOS DE DENIA GRUPO HLA SL. INMO ASISA SL.Datos registrales. T 3945 , F 66, S 8, H A 13693, I/A 37 (14.12.16).
25 de Agosto de 2016Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: HLA LAVINIA SALUD SL. Datos registrales. T 3945 , F 66, S 8, HA 13693, I/A 36 (17.08.16).
13 de Mayo de 2016Nombramientos. Apoderado: RIVERA GONZALEZ MARTIN. Datos registrales. T 3303 , F 181, S 8, H A 13693, I/A 35 ( 5.05.16).
13 de Marzo de 2015Nombramientos. Apo.Manc.: SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL;RODRIGUEZ VILLA MATONS ANDRES;ALCALDEGOMEZ MARIA DOLORES;CABALLERO CABALLERO MARIANO;TIRADO GUALLART JESUS. Apo.Sol.: ALCALDE GOMEZ MARIADOLORES;TIRADO GUALLART JESUS. Apo.Man.Soli: ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES;TIRADO GUALLART JESUS.Apo.Manc.: SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL;RODRIGUEZ VILLA MATONS ANDRES;CABALLERO CABALLEROMARIANO. Apo.Sol.: ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES;TIRADO GUALLART JESUS. Datos registrales. T 3303 , F 181, S 8, H A13693, I/A 34 ( 5.03.15).
09 de Marzo de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.202.020,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.076.211,10 Euros. Datos registrales. T 3303 , F 180, S8, H A 13693, I/A 33 (27.02.15).
24 de Diciembre de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: IVORRA MIRALLES FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: IVORRA MIRALLESFRANCISCO;LORENZO SAEZ DIEGO;CABALLERO CABALLERO MARIANO. Presidente: IVORRA MIRALLES FRANCISCO.Vicepresid.: LORENZO SAEZ DIEGO. Secretario: CABALLERO CABALLERO MARIANO. Consejero: NAVARRO RIBERO RICARDO.Co.De.Ma.So: NAVARRO RIBERO RICARDO. Cons.Del.Man: IVORRA MIRALLES FRANCISCO. Otros conceptos: Cambio delOrgano de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Modificado el nombre del domicilio social en virtud deinforme del ayuntamiento de D茅nia, por el cual actualmente al direcci贸n correcta es Partida Madrigueres Sud, n煤mero 8. Cambio dedomicilio social. PTDA MADRIGUERS SUD 8 (DENIA). Datos registrales. T 3303 , F 180, S 8, H A 13693, I/A 32 (17.12.14).
05 de Diciembre de 2013Revocaciones. Apo.Sol.: DIAZ-MINGUEZ RAMIREZ ANGEL. Apo.Man.Soli: DIAZ-MINGUEZ RAMIREZ ANGEL;DIAZ-MINGUEZRAMIREZ ANGEL. Nombramientos. Apoderado: NAVARRO RIBERO RICARDO. Apo.Sol.: LOPEZ JERICO FRANCISCOJAVIER;RIVERA GONZALEZ MARTIN. Datos registrales. T 2093 , F 225, S 8, H A 13693, I/A 31 (27.11.13).
04 de Diciembre de 2013Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2093 , F 225, S 8, H A 13693, I/A30 (26.11.13).
27 de Diciembre de 2012Nombramientos. Apoderado: DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE. Datos registrales. T 2093 , F 224, S 8, H A 13693, I/A 29(18.12.12).
08 de Octubre de 2012Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2093 , F 224, S 8, H A 13693, I/A28 (26.09.12).
10 de Mayo de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 500.040,32 Euros. Resultante Suscrito: 4.874.191,10 Euros. Datos registrales. T 2093 , F 224, S 8,H A 13693, I/A 27 (28.04.11).
18 de Junio de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 673.131,20 Euros. Resultante Suscrito: 4.374.150,78 Euros. Datos registrales. T 2093 , F 224, S 8,H A 13693, I/A 26 ( 9.06.10).
17 de Junio de 2010Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2093 , F 224, S 8, H A 13693, I/A25 ( 7.06.10).
01 de Junio de 2010Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2093 , F 224, S 8, H A 13693, I/A24 (20.05.10).
02 de Noviembre de 2009Nombramientos. Apo.Man.Soli: NAVARRO RIBERO RICARDO;CABALLERO CABALLERO MARIANO;DIAZ-MINGUEZ RAMIREZANGEL. Datos registrales. T 2093 , F 155, S 8, H A 13693, I/A 23 (21.10.09).
23 de Abril de 2009Nombramientos. Apo.Sol.: NAVARRO RIBERO RICARDO;CABALLERO CABALLERO MARIANO;DIAZ-MINGUEZ RAMIREZANGEL. Apo.Man.Soli: NAVARRO RIBERO RICARDO;CABALLERO CABALLERO MARIANO;DIAZ-MINGUEZ RAMIREZ ANGEL.Datos registrales. T 2093 , F 155, S 8, H A 13693, I/A 22 ( 8.04.09).
21 de Abril de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 420.707,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.701.019,58 Euros. Datos registrales. T 2093 , F 155, S 8,H A 13693, I/A 21 ( 7.04.09).
20 de Abril de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 500.040,32 Euros. Resultante Suscrito: 3.280.312,58 Euros. Datos registrales. T 2093 , F 155, S 8,H A 13693, I/A 20 ( 6.04.09).
17 de Abril de 2009Cambio de objeto social. a.- La organizaci贸n, direcci贸n, gesti贸n e intermediaci贸n para la prestaci贸n de servicios de asistencia cl铆nicageneral y tratamientos m茅dico-quir煤rgicos de todo tipo de enfermedades humanas y cualquier servicio sanitario. b.- La construcci贸n,adquisici贸n, arrendamiento, instalaci贸n, direcci贸n y expl. Datos registrales. T 2093 , F 154, S 8, H A 13693, I/A 19 ( 3.04.09).