Actos BORME de Poliester Extrusionado Sl
12 de Febrero de 2019Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 635/2010. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 21/01/2019. Auto de conclusi贸n delconcurso. Finalizacion de la fase de liquidacion. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA. Juez: EDUARDOPASTOR MARTINEZ. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 635/2010. Fecha de resoluci贸n 22/09/2010. Revocaci贸n deadministradores concursales. Juzgado: num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA. Juez: CUTILLAS TORNS JOSEMARIA. Administrador Concursal. Fecha 21/01/2019, NIF/CIF 21632875H. CALBO SILVESTRE JOSE LUIS. Situaci贸n concursal.Procedimiento concursal 635/2010. Fecha de resoluci贸n 22/09/2010. Revocaci贸n de administradores concursales. Juzgado: num. 3JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA. Juez: CUTILLAS TORNS JOSE MARIA. Administrador Concursal. Fecha 21/01/2019,NIF/CIF 24376294C. VALERO MU脩OZ JAIME. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 635/2010. Fecha de resoluci贸n22/09/2010. Revocaci贸n de administradores concursales. Juzgado: num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA. Juez:CUTILLAS TORNS JOSE MARIA. Administrador Concursal. Fecha 21/01/2019, NIF/CIF B96265384. MARTINEZ SOLERAHERMANOS SL. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 635/2010. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 21/01/2019. Cese de laslimitaciones de las facultades de administraci贸n. Juzgado: num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA. Juez: EDUARDOPASTOR MARTINEZ. Extinci贸n. Datos registrales. T 9087, L 6371, F 219, S 8, H V 123155, I/A 21 ( 5.02.19).
31 de Diciembre de 2010Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 635/2010. Fecha de resoluci贸n 22/09/2010. Nombramiento de administradores.Juzgado: num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA. Juez: CUTILLAS TORNS JOSE MARIA. Administrador Concursal.Fecha 22/09/2010, NIF/CIF B96265384. MARTINEZ SOLERA HERMANOS SL. Datos registrales. T 9087, L 6371, F 218, S 8, H V123155, I/A 19 (22.12.10).
11 de Octubre de 2010Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 635/2010. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 22/09/2010. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA. Juez: CUTILLAS TORNS JOSE MARIA.Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 635/2010. Fecha de resoluci贸n 22/09/2010. Nombramiento de administradores.
20 de Agosto de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: ORTIZ VAAMONDE JAVIER;MAGRO GONZALEZ AGUSTIN;BARROETA TORRES GUSTAVO.Secretario: ORTIZ VAAMONDE JAVIER. Consejero: ACCUORE REAL ESTATE SL. Presidente: ACCUORE REAL ESTATE SL.Revocaciones. VsecrNoConsj: DE LUCAS DO脩ORO RAUL;RUIZ GIMENO YASMINA. Nombramientos. Adm. Unico: AMURAINDUSTRIAL PARTNERS SL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aAdministrador 煤nico. Otros conceptos: CANOSA PEREZ VICENTE, DNI 51352782S, ha sido designado persona f铆sicarepresentante del Administrador Unico, la mercantil "AMURA INDUSTRIAL PARTNERS SL". Datos registrales. T 9087, L 6371, F218, S 8, H V 123155, I/A 17 (11.08.10).
12 de Agosto de 2010Revocaciones. Apo.Manc.: MARTINEZ DE LOS SANTOS ANGEL;RAUSELL FONTESTAD GUILLERMO. Datos registrales. T9087, L 6371, F 218, S 8, H V 123155, I/A 16 ( 3.08.10).
29 de Marzo de 2010Revocaciones. Apo.Manc.: RAUSELL FONTESTAD GUILLERMO. Apoderado: MARTINEZ DELGADO FERNANDO. Apo.Manc.:MARTINEZ DE LOS SANTOS ANGEL. Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ DE LOS SANTOS ANGEL;RAUSELL FONTESTADGUILLERMO. Apoderado: MARTINEZ DELGADO FERNANDO. Datos registrales. T 9087, L 6371, F 216, S 8, H V 123155, I/A 15(17.03.10).
28 de Diciembre de 2009Nombramientos. Consejero: ACCUORE REAL ESTATE SL. Otros conceptos: Se fija el n煤mero de miembros del Organo deAdministraci贸n en cuatro. Datos registrales. T 8717, L 6004, F 12, S 8, H V 123155, I/A 11 (16.12.09).
Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ DE LOS SANTOS ANGEL;RAUSELL FONTESTAD GUILLERMO. Datos registrales. T8717, L 6004, F 13, S 8, H V 123155, I/A 12 (16.12.09).
Ceses/Dimisiones. Presidente: MAGRO GONZALEZ AGUSTIN. Con.Delegado: MAGRO GONZALEZ AGUSTIN. Nombramientos.Presidente: ACCUORE REAL ESTATE SL. VsecrNoConsj: DE LUCAS DO脩ORO RAUL;RUIZ GIMENO YASMINA. Datos registrales.T 9087, L 6371, F 215, S 8, H V 123155, I/A 13 (16.12.09).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ DELGADO FERNANDO. Datos registrales. T 9087, L 6371, F 215, S 8, H V 123155, I/A14 (16.12.09).
16 de Octubre de 2009Revocaciones. Apoderado: MA脩A ESCARIHUELA FRANCISCO;ESLAVA HERNANDEZ ELISEO. Datos registrales. T 8717, L6004, F 12, S 8, H V 123155, I/A 10 ( 6.10.09).
12 de Agosto de 2009Ceses/Dimisiones. Secretario: MAGRO GONZALEZ AGUSTIN. Nombramientos. Secretario: ORTIZ VAAMONDE JAVIER.Presidente: MAGRO GONZALEZ AGUSTIN. Apo.Sol.: EGUIA VENTURA I脩AKI;CANOSA PEREZ VICENTE. Datos registrales. T8717, L 6004, F 11, S 8, H V 123155, I/A 9 ( 3.08.09).
26 de Mayo de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: ARTOLA GONZALEZ IGNACIO;XERCAVINS LLUCH JOSE MARIA;REYZA 2006 INVERSIONES SL.Nombramientos. Consejero: BARROETA TORRES GUSTAVO. Datos registrales. T 8717, L 6004, F 10, S 8, H V 123155, I/A 6(15.05.09).
Ceses/Dimisiones. Consejero: ESLAVA HERNANDEZ ELISEO. Con.Delegado: ESLAVA HERNANDEZ ELISEO. Datos registrales.T 8717, L 6004, F 11, S 8, H V 123155, I/A 7 (15.05.09).
Ceses/Dimisiones. Consejero: MA脩A ESCARIHUELA FRANCISCO. Presidente: MA脩A ESCARIHUELA FRANCISCO.Con.Delegado: MA脩A ESCARIHUELA FRANCISCO. Datos registrales. T 8717, L 6004, F 11, S 8, H V 123155, I/A 8 (15.05.09).