Actos BORME de Powerinstep Sl
25 de Febrero de 2020Ampliaci贸n de capital. Capital: 22.900,00 Euros. Resultante Suscrito: 293.800,00 Euros. Modificaciones estatutarias.MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN FECHA 15/11/2019. Otros conceptos: PERDIDA DEUNIPERSONALIDAD. Datos registrales. T 46380 , F 62, S 8, H B 452731, I/A 7 (17.02.20).
29 de Octubre de 2019Ampliaci贸n de capital. Capital: 108.320,00 Euros. Resultante Suscrito: 270.900,00 Euros. Cambio de objeto social. (CNAE 1520)A) LA FABRICACION, COMPRA Y VENTA, AL MAYOR Y MENOR, DISTRIBUCION, IMPORTACION, EXPORTACION, DE MATERIALDEPORTIVO, INCLUYENDO CALZADO DEPORTIVO, MATERIAL DE REHABILITACION Y/O ORTOPEDIA, ACCESORIOS,EQUIPAMIEN... Datos registrales. T 44323 , F 16, S 8, H B 452731, I/A 6 (21.10.19).
30 de Agosto de 2019Otros conceptos: DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: CIFOSPORT LICENSING S.L. Datos registrales. T44323 , F 15, S 8, H B 452731, I/A 5 (23.08.19).
21 de Diciembre de 2016Revocaciones. ADM.UNICO: SOLER RELLUI ELISABET. Nombramientos. ADM.UNICO: BORES CIFO VICENTE.Modificaciones estatutarias. ARTICULO 19: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datosregistrales. T 44323 , F 15, S 8, H B 452731, I/A 4 (13.12.16).
21 de Marzo de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 159.580,00 Euros. Resultante Suscrito: 162.580,00 Euros. Datos registrales. T 44323 , F 14, S 8, HB 452731, I/A 3 (11.03.16).
06 de Mayo de 2015Nombramientos. APODERAD.SOL: BORES CIFO VICENTE. Datos registrales. T 44323 , F 13, S 8, H B 452731, I/A 2 (27.04.15).
27 de Mayo de 2014Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 7.03.14. Objeto social: FABRICACION,COMPRA,VENTA,AL MAYOR YMENOR,DISTRIBUCION,IMPORTACION,EXPORTACION DE MATERIAL DEPORTIVO,INCLUYENDO CALZADODEPORTIVO,MATERIAL DE REHABILITACION Y/O ORTOPEDIA,ACCESORIOS,EQUIPAMIENTO,ETC. Domicilio: CL NUMANCIANum.201 P.7 PTA.1 (BARCELONA). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. ADM.UNICO: SOLER RELLUI ELISABET. Datosregistrales. T 44323 , F 11, S 8, H B 452731, I/A 1 (19.05.14).