Actos BORME de Ppg Coatings Spain Sa
01 de Febrero de 2018Otros conceptos: certificación conforme al art. 233.2 del RRM. Extinción. Datos registrales. T 33259 , F 112, S 8, H M 173996, I/A111 (24.01.18).
22 de Diciembre de 2017Otros conceptos: CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL POR PLAZO DE SEIS MESES, DE CONFORMIDAD CON LOPRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 DEL VIGENTE REGLAMENTO. Datos registrales. T 11036 , F 150, S 8, H M 173996, I/A110M (14.12.17).
20 de Julio de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: BRAVO MANCHEÑO IGNACIO CELSO;JIMENEZ ESTRADA FRANCISCO JESUS. Revocaciones.Apoderado: SUEIRO FERNANDEZ JOSE MANUEL;SUEIRO FERNANDEZ JOSE MANUEL. Nombramientos. Consejero:NAVARRO JURADO JUAN JOSE;PACIOS GARCIA JUAN. Datos registrales. T 33259 , F 112, S 8, H M 173996, I/A 110 (13.07.17).
10 de Junio de 2016Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ AHEDO TRINIDAD. Datos registrales. T 33259 , F 111, S 8, H M 173996, I/A 109 (3.06.16).
23 de Marzo de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: LOZANO MORE EUGENI. Revocaciones. Apoderado: SERRANO MARTINEZ TOMAS.Nombramientos. Apo.Sol.: HERNANDO GIMENO JESUS. Consejero: JIMENEZ ESTRADA FRANCISCO JESUS. Otros conceptos:Revocados el poder conferido a favor de D. Tomás Serrano Martínez en la inscripción 65&; y de los poderes conferidos a favor de D.José López Ruiz, D. Gregorio Carrión García y D. Tomás Serrano Martínez en la inscripción 75&. Datos registrales. T 33259 , F 111,S 8, H M 173996, I/A 108 (11.03.16).
10 de Agosto de 2015Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: PPG IBERICA SALES & SERVICES SL. Datos registrales. T 33259, F 110, S 8, H M 173996, I/A 107 (29.07.15).
08 de Junio de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: DE CONINCK JACQUES. Presidente: DE CONINCK JACQUES. Secretario: LLOVET DE VICENTERAFAEL. Consejero: LLOVET DE VICENTE RAFAEL. Con.Delegado: DE CONINCK JACQUES. Consejero: MEAN NICOLASPATRICK MARIE;HERNANDO GIMENO JESUS. Revocaciones. Apoderado: LOPEZ RUIZ JOSE ANTONIO;CARRION GARCIAGREGORIO;BERJILLOS VAZQUEZ JUAN;ECHEANDIA BARTUREN EDUARDO. Nombramientos. SecreNoConsj: LLOVET DEVICENTE RAFAEL. Consejero: HERNANDO GIMENO JESUS. Presidente: HERNANDO GIMENO JESUS. Consejero: LOZANOMORE EUGENI;BRAVO MANCHEÑO IGNACIO CELSO. Apoderado: SUEIRO FERNANDEZ JOSE MANUEL. Cambio de domiciliosocial. PLAZA DE ESPAÑA, NUMERO 12 1º A (MADRID). Datos registrales. T 11036 , F 165, S 8, H M 173996, I/A 106 (28.05.15).
29 de Octubre de 2009Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 11036 , F 165, S 8, H M 173996,I/A 105 (19.10.09).