Actos BORME de Pra Iberia Sl
05 de Abril de 2023Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 42671 , F 150, S 8, H M 94984, I/A 59 (29.03.23).
10 de Marzo de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: ARRIBAS SANCHEZ GUSTAVO. Cons.Del.Sol: ARRIBAS SANCHEZ GUSTAVO. Nombramientos.Consejero: MARTINEZ VICENTE LUIS. Cons.Del.Sol: MARTINEZ VICENTE LUIS. Datos registrales. T 42671 , F 150, S 8, H M94984, I/A 58 ( 4.03.23).
09 de Mayo de 2022Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 30565 , F 189, S 8, H M 94984, I/A 56 (29.04.22).
10 de Febrero de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ VICENTE LUIS. Datos registrales. T 30565 , F 189, S 8, H M 94984, I/A 55 ( 3.02.22).
26 de Enero de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ VICENTE LUIS. Cons.Del.Sol: MARTINEZ VICENTE LUIS. Nombramientos. Consejero:ARRIBAS SANCHEZ GUSTAVO. Cons.Del.Sol: ARRIBAS SANCHEZ GUSTAVO. Datos registrales. T 30565 , F 188, S 8, H M94984, I/A 54 (19.01.22).
25 de Enero de 2022Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: PRA GROUP EUROPE AS. Datos registrales. T 30565 , F 188, S 8,H M 94984, I/A 53 (18.01.22).
23 de Febrero de 2021Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 30565 , F 188, S 8, H M 94984, I/A 52 (16.02.21).
07 de Septiembre de 2020Nombramientos. Apoderado: ALMUZARA ALMAIDA CRISTINA. Datos registrales. T 30565 , F 187, S 8, H M 94984, I/A 50(31.08.20).
Nombramientos. Apoderado: RICO DEL VALLE MARIA. Datos registrales. T 30565 , F 187, S 8, H M 94984, I/A 51 (31.08.20).
01 de Julio de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: DOKSET LEIF HENNING. Cons.Del.Sol: DOKSET LEIF HENNING. Nombramientos. Consejero:OWEN JAMES RICHARD. Cons.Del.Sol: OWEN JAMES RICHARD. Datos registrales. T 30565 , F 187, S 8, H M 94984, I/A 49(24.06.19).
13 de Diciembre de 2018Revocaciones. Apoderado: SOARES DE OLIVEIRA LOPES SARAIVA FRANCISCO. Datos registrales. T 30565 , F 186, S 8, H M94984, I/A 48 ( 4.12.18).
16 de Agosto de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: PATEL TIKENDRA. Presidente: PATEL TIKENDRA. Cons.Del.Sol: PATEL TIKENDRA.Nombramientos. Consejero: SJOLUND PER MARTIN. Presidente: SJOLUND PER MARTIN. Cons.Del.Sol: SJOLUND PER MARTIN.Datos registrales. T 30565 , F 186, S 8, H M 94984, I/A 47 ( 6.08.18).
12 de Abril de 2018Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ CANIVELL IGNACIO;SOARES DE OLIVEIRA LOPES SARAIVA FRANCISCO. Datos
28 de Febrero de 2018Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 30565 , F 185, S 8, H M 94984, I/A 45 (21.02.18).
23 de Mayo de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: KELLER THOMAS. Datos registrales. T 30565 , F 185, S 8, H M 94984, I/A 44 (16.05.17).
14 de Noviembre de 2016Revocaciones. Apo.Sol.: SCHEPERS DIANNE JOHANNA MARIA ARDINE. Apo.Man.Soli: GALLEGO GALLEGOMONTSERRAT;ARRIBAS SANCHEZ GUSTAVO. Apo.Sol.: ROMERO SOLER EVA. Nombramientos. Apoderado: GALLEGOGALLEGO MONTSERRAT;ARRIBAS SANCHEZ GUSTAVO;MARTOS PELOCHE MARIA DOLORES;ROMERO SOLER EVA. Datos
11 de Agosto de 2016Otros conceptos: Con fecha 1 de diciembre de 2015 el socio único de la sociedad " Aktiv Kapital Financial Services AS" cambió sudenominación por la de "PRA GROUP FINANCIAL SERVICES AS". Datos registrales. T 30565 , F 184, S 8, H M 94984, I/A 42 (3.08.16).
04 de Agosto de 2016Revocaciones. Apo.Sol.: ARRIBAS SANCHEZ GUSTAVO;MUÑOZ FERRANDO MARIA TERESA. Apoderado: GALLEGO GALLEGOMONTSERRAT. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GALLEGO GALLEGO MONTSERRAT;ARRIBAS SANCHEZ GUSTAVO. Apo.Sol.:ROMERO SOLER EVA. Datos registrales. T 30565 , F 183, S 8, H M 94984, I/A 41 (27.07.16).
13 de Mayo de 2016Nombramientos. Apoderado: GALLEGO GALLEGO MONTSERRAT. Datos registrales. T 30565 , F 183, S 8, H M 94984, I/A 40 (6.05.16).
06 de Noviembre de 2015Cambio de domicilio social. C/ ALBASANZ 16, PISO 3º (MADRID). Datos registrales. T 30565 , F 182, S 8, H M 94984, I/A 39(28.10.15).
29 de Septiembre de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: HERBERG CANELA PABLO. Datos registrales. T 30565 , F 182, S 8, H M 94984, I/A 38 (21.09.15).
15 de Junio de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: SCHEPERS DIANNE JOHANNA MARIA ARDINE;KELLER THOMAS. Datos registrales. T 30565 , F182, S 8, H M 94984, I/A 37 ( 5.06.15).
24 de Febrero de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: ARRIBAS SANCHEZ GUSTAVO. Secretario: ARRIBAS SANCHEZ GUSTAVO. Nombramientos.SecreNoConsj: ARRIBAS SANCHEZ GUSTAVO. Apo.Sol.: MUÑOZ FERRANDO MARIA TERESA;ALMUZARA ALMAIDA CRISTINA.
10 de Febrero de 2015Modificaciones estatutarias. 8 bis. Acciones/Participaciones.-. Datos registrales. T 30565 , F 181, S 8, H M 94984, I/A 35 (3.02.15).
19 de Enero de 2015Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 30565 , F 180, S 8, H M 94984, I/A 34 ( 8.01.15).