Buscador CIF Logo

Actos BORME Praxair Iberica Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Praxair Iberica Sa

Actos BORME Praxair Iberica Sa - A31016306

Tenemos registrados 11 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Praxair Iberica Sa con CIF A31016306

馃敊 Perfil de Praxair Iberica Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Praxair Iberica Sa

19 de Octubre de 2011
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 27969 , F 39, S 8, H M 48011, I/A 67 ( 6.10.11).

27 de Julio de 2011
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 27969 , F 39, S 8, H M 48011, I/A66 (15.07.11).

19 de Julio de 2011
Revocaciones. Apoderado: PUERTAS MARTINEZ ANTONIO;PUERTAS MARTINEZ ANTONIO. Nombramientos. Apoderado:CABALLERO CARBONELL JOSE FRANCISCO;ABASCAL LLANO PONTE EUSEBIO;LUENGO ZAMORANO JOSE VICENTE;AMORLOPEZ MARIA SOL;GARCIA PRADO COVADONGA. Datos registrales. T 27969 , F 39, S 8, H M 48011, I/A 65 ( 8.07.11).

11 de Noviembre de 2010
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 27969 , F 38, S 8, H M 48011, I/A64 (29.10.10).

08 de Noviembre de 2010
Revocaciones. Apoderado: MERLINO SANCHEZ ELVIRA ROCIO;MERLINO SANCHEZ-ELVIRA ROCIO. Apo.Man.Soli: MERLINOSANCHEZ ELVIRA ROCIO. Apoderado: FIGUEIREDO MENEZES EDUARDO;MERLINO SANCHEZ-ELVIRA ROCIO. Apo.Man.Soli:FIGUEIREDO MENEZES EDUARDO;MERLINO SANCHEZ-ELVIRA ROCIO. Datos registrales. T 27969 , F 38, S 8, H M 48011, I/A63 (26.10.10).

05 de Noviembre de 2010
Nombramientos. Apoderado: SKARE TODD ALAN;LLOSENT DE NARDIZ MARIA DEL DULCE NOMBRE;GIL ELEJOSTEEDUARDO;CABALLERO CARBONELL JOSE FRANCISCO;LUENGO ZAMORANO JOSE VICENTE;OSADO ROBLEDOADELAIDA;SAINZ DE LOS TERREROS Y DEL YERRO CARLOS MIGUEL;ABASCAL LLANO PONTE EUSEBIO Datos registrales. T27969 , F 36, S 8, H M 48011, I/A 62 (26.10.10).

07 de Octubre de 2010
Ceses/Dimisiones. Representan: FIGUEIREDO MENEZES EDUARDO. Nombramientos. Representan: SKARE TODD ALAN.Datos registrales. T 20375 , F 194, S 8, H M 48011, I/A 61 (28.09.10).

04 de Agosto de 2010
Nombramientos. Apo.Manc.: GIL ELEJOSTE EDUARDO;CABALLERO CARBONELL JOSE FRANCISCO;LUENGO ZAMORANOJOSE VICENTE;IBARRA CORTADI ALFONSO;FORNIELES RUEDA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 20375 , F 194, S 8, H M48011, I/A 60 (23.07.10).

08 de Octubre de 2009
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 20375 , F 194, S 8, H M 48011, I/A59 (28.09.09).

14 de Julio de 2009
Nombramientos. Apoderado: GARCIA DE LA FUENTE JAIME;INSUELA LORENZO SANTIAGO. Datos registrales. T 20375 , F193, S 8, H M 48011, I/A 58 ( 2.07.09).

26 de Junio de 2009
Revocaciones. Apoderado: LOPEZ HERNANDEZ GONZALO. Apo.Manc.: LOPEZ HERNANDEZ GONZALO;LOPEZ HERNANDEZGONZALO. Nombramientos. Apo.Manc.: CERPAVICIUS GOLDSTEIN FABIAN DANIEL;GIL ELEJOSTE EDUARDO;ABASCALLLANO PONTE EUSEBIO;CABALLERO CARBONELL JOSE FRANCISCO;LUENGO ZAMORANO JOSE VICENTE;FORNIELESRUEDA JOSE MANUEL;PEREZ MENENDEZ ANTONIO. Datos registrales. T 20375 , F 193, S 8, H M 48011, I/A 57 (16.06.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n