Actos BORME de Prefabricados Beranga Sa
17 de Marzo de 2022Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 434/2013. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 11/02/2022. Auto de conclusi贸n delconcurso. Insuficiencia de la masa activa. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE SANTANDER. Juez:CARLOS MARTINEZ DE MARIGORTA MENENDEZ. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 434/2013. Fecha de resoluci贸n15/11/2013. Revocaci贸n de administradores concursales. Juzgado: num. 1 JUZGADO MERCANTIL DE SANTANDER. Juez: CARLOSMARTINEZ DE MARIGORTA MENEDEZ. Administrador Concursal. Fecha 11/02/2022, NIF/CIF B39565924. BASTIDA & PONTONESSL. Extinci贸n. Datos registrales. T 536 , F 41, S 8, H S 2662, I/A 24 ( 7.03.22).
31 de Enero de 2014Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 434/2013. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 15/11/2013. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 1 JUZGADO MERCANTIL DE SANTANDER. Juez: CARLOS MARTINEZ DE MARIGORTAMENEDEZ. Datos registrales. T 536 , F 41, S 8, H S 2662, I/A 23 (27.01.14).
19 de Diciembre de 2013Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 236.197,58 Euros. Desembolsado: 236.197,58 Euros. Resultante Suscrito: 356.400,00 Euros.Resultante Desembolsado: 356.400,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 125.000,00 Euros. Desembolsado: 125.000,00 Euros.Resultante Suscrito: 481.400,00 Euros. Resultante Desembolsado: 481.400,00 Euros. Datos registrales. T 536 , F 40, S 8, H S 2662,I/A 22 (12.12.13).
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 434/2013. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 15/11/2013. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 1 JUZGADO MERCANTIL DE SANTANDER. Juez: CARLOS MARTINEZ DE MARIGORTAMENEDEZ. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 434/2013. Fecha de resoluci贸n 15/11/2013. Nombramiento deadministradores. Juzgado: num. 1 JUZGADO MERCANTIL DE SANTANDER. Juez: CARLOS MARTINEZ DE MARIGORTAMENEDEZ. Administrador Concursal. Fecha 15/11/2013, NIF/CIF B39565924. BASTIDA & PONTONES SL. Datos registrales. T 536, F 40, S 8, H S 2662, I/A A (13.12.13).
08 de Octubre de 2013Nombramientos. Auditor: COMAS VALLS EDUARDO. Datos registrales. T 536 , F 40, S 8, H S 2662, I/A 21 ( 1.10.13).
22 de Enero de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 360.607,26 Euros. Resultante Suscrito: 120.202,42 Euros. Datos registrales. T 466 , F195, S 8, H S 2662, I/A 20 (11.01.13).
21 de Junio de 2012Revocaciones. Auditor: LOPEZ D HERS CARLOS. Aud.Supl.: BDR AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datosregistrales. T 466 , F 195, S 8, H S 2662, I/A 19 (11.06.12).
08 de Julio de 2011Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: FERNANDEZ RANCA脩O MODESTO LUIS. Consejero: FERNANDEZ RANCA脩O MODESTO LUIS.Datos registrales. T 466 , F 195, S 8, H S 2662, I/A 18 (28.06.11).
25 de Noviembre de 2010Nombramientos. Cons.Del.Man: RUIGOMEZ CUBAS YOHANA;RUIGOMEZ TRUEBA ALICIA;SANTA COLOMA SAN EMETERIOJUAN JOSE;RUIGOMEZ GOMEZ JAVIER. Datos registrales. T 466 , F 195, S 8, H S 2662, I/A 17 (15.11.10).
20 de Septiembre de 2010Nombramientos. Aud.Supl.: BDR AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Auditor: LOPEZ D HERS CARLOS. Datosregistrales. T 466 , F 195, S 8, H S 2662, I/A 16 ( 8.09.10).
08 de Julio de 2010Reelecciones. Auditor: LAIZ SANCHEZ JOSE ALBERTO. Aud.Supl.: RUIZ DEL HOYO SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL.Datos registrales. T 466 , F 194, S 8, H S 2662, I/A 14 (29.06.10).
Ceses/Dimisiones. Consejero: RUIGOMEZ PE脩A LINO. Presidente: RUIGOMEZ PE脩A LINO. Consejero: RUIGOMEZ PE脩AFELIPE. Secretario: RUIGOMEZ PE脩A FELIPE. Consejero: RUIGOMEZ PE脩A ANGEL;RUIGOMEZ PE脩A EUGENIO;FERNANDEZRANCA脩O MODESTO LUIS. Nombramientos. Consejero: RUIGOMEZ GOMEZ JAVIER. Presidente: RUIGOMEZ GOMEZ JAVIER.Consejero: FERNANDEZ RANCA脩O MODESTO LUIS. Vicepresid.: FERNANDEZ RANCA脩O MODESTO LUIS. Consejero: SANTACOLOMA SAN EMETERIO JUAN JOSE. Secretario: SANTA COLOMA SAN EMETERIO JUAN JOSE. Consejero: RUIGOMEZ CUBASYOHANA;RUIGOMEZ TRUEBA ALICIA. Datos registrales. T 466 , F 194, S 8, H S 2662, I/A 15 (29.06.10).