Actos BORME de Prefatrans Sl
18 de Enero de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: TOMAS ENRIQUE NEUHAUS NEVADO;SERGIO DAVID NARRO MARTINEZ. Nombramientos.Presidente: HIGINI MANUEL ALFAGEME CARRERA. Consejero: HIGINI MANUEL ALFAGEME CARRERA. Secretario: DANIELNOCERA GIMENEZ. Consejero: DANIEL NOCERA GIMENEZ;LORENZO PEDRERO ALVAREZ. Otros conceptos: Cambio delOrgano de Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 277, L 277, F 159, S 8, H TE5611, I/A 13 (10.01.22).
03 de Septiembre de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: ANENTO MARTINEZ ROBERTO. Apo.Man.Soli: LOPEZ ROMERO ANTONIO. Apo.Sol.: SORIANOROTELLAR MARIA DEL PILAR. Apo.Man.Soli: LAURA MARTINEZ VIVAR. Apo.Sol.: LAURA MARTINEZ VIVAR. Apo.Man.Soli:SORIANO ROTELLAR MARIA DEL PILAR. Apo.Sol.: SORIANO ROTELLAR MARIA DEL PILAR. Apo.Man.Soli: LAURA MARTINEZVIVAR;LAURA MARTINEZ VIVAR;SORIANO ROTELLAR MARIA DEL PILAR;MILLAN PINA GABRIEL JOSE. Datos registrales. T273, L 273, F 53, S 8, H TE 5611, I/A 12 (17.08.20).
29 de Octubre de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: SORIANO ROTELLAR MARIA DEL PILAR;SERGIO DAVID NARRO MARTINEZ;ANENTOMARTINEZ ROBERTO;LAURA MARTINEZ VIVAR. Apo.Sol.: MILLAN PINA GABRIEL JOSE. Datos registrales. T 264, L 264, F 85, S8, H TE 5611, I/A 10 (21.10.19).
Modificaciones estatutarias. Fecha Cierre Ejercicio: 31/12. Art铆culo de los Estatutos : "Art铆culo 3.- Duraci贸n, fecha de comienzo desus operaciones y cierre de los ejercicios sociales. La duraci贸n de la sociedad ser谩 indefinida y dar谩 comienzo a sus operaciones el d铆ade la fecha de la escritura de constituci贸n. El ejercicio social comenzar谩 el d铆a 1 de enero y finalizar谩 el d铆a 31 de. Datos registrales.T 273, L 273, F 53, S 8, H TE 5611, I/A 11 (21.10.19).
04 de Junio de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: JAIME PRIETO GALIANA. Nombramientos. Adm. Solid.: SERGIO DAVID NARRO MARTINEZ.Datos registrales. T 256, L 256, F 117, S 8, H TE 5611, I/A 7 (27.05.19).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MONTSERRAT BUENO MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: SORIANO ROTELLARMARIA DEL PILAR;LAURA MARTINEZ VIVAR;MILLAN PINA GABRIEL JOSE. Datos registrales. T 256, L 256, F 117, S 8, H TE5611, I/A 8 (27.05.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: PABLO MIGUEL FERNANDEZ CORTIJO;BLANCA BARBANOJ SILLES;JUAN FERRERASESTRADA;ANDREA GALARRAGA RODRIGUEZ;I脩IGO MARIA VALDENEBRO MONZON. Datos registrales. T 264, L 264, F 85, S8, H TE 5611, I/A 9 (27.05.19).
15 de Marzo de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ERUSAN INVERSIONES 2007 SL. Nombramientos. Adm. Solid.: JAIME PRIETOGALIANA;TOMAS ENRIQUE NEUHAUS NEVADO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aAdministradores solidarios. Datos registrales. T 251, L 251, F 132, S 8, H TE 5611, I/A 3 (27.02.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: SORIANO ROTELLAR MARIA DEL PILAR;LAURA MARTINEZ VIVAR. Datos registrales. T 251, L 251,
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SORIANO ROTELLAR MARIA DEL PILAR;LAURA MARTINEZ VIVAR. Datos registrales. T 251, L251, F 132, S 8, H TE 5611, I/A 5 (27.02.19).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MONTSERRAT BUENO MIGUEL ANGEL;LAURA MARTINEZ VIVAR. Datos registrales. T 256, L256, F 116, S 8, H TE 5611, I/A 6 (27.02.19).
20 de Marzo de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: ANENTO MARTINEZ ROBERTO;SORIANO ROTELLAR MARIA DEL PILAR. Apo.Man.Soli: LOPEZROMERO ANTONIO. Datos registrales. T 251, L 251, F 130, S 8, H TE 5611, I/A 2 ( 6.03.14).
10 de Octubre de 2013Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 1.10.13. Objeto social: Cualquier actividad auxiliar, complementaria o anexa para la funci贸ndel transporte de mercanc铆as, incluyendo intermediaci贸n, agencia, transitaria y cualesquiera otros servicios de gesti贸n, mediaci贸n en eltransporte, subcontrataci贸n del mismo o de sus servicios de carga, estiba y descarga. Domicilio: POLIG VENTA DEL BARRO S/N(PUEBLA DE HIJAR (LA)). Capital: 100.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ERUSAN INVERSIONES2007 SL. Nombramientos. Adm. Unico: ERUSAN INVERSIONES 2007 SL. Datos registrales. T 251, L 251, F 128, S 8, H TE 5611,I/A 1 ( 1.10.13).