Buscador CIF Logo

Actos BORME Premier Pharma Holding Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Premier Pharma Holding Sl

Actos BORME Premier Pharma Holding Sl - B85367126

Tenemos registrados 29 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Premier Pharma Holding Sl con CIF B85367126

馃敊 Perfil de Premier Pharma Holding Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Premier Pharma Holding Sl

18 de Enero de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: JARDINE HIRD EDWARD DARBYSHIRE. Datos registrales. T 35552 , F 45, S 8, H M 458005, I/A36 (11.01.23).

13 de Agosto de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: LLATAS SALVADOR VICENTE. Revocaciones. Apo.Sol.: LLATAS SALVADOR VICENTE. Datosregistrales. T 35552 , F 44, S 8, H M 458005, I/A 32 ( 6.08.20).

05 de Junio de 2018
Revocaciones. Apoderado: MARTIN-RABADAN MURO MIGUEL. Datos registrales. T 35552 , F 42, S 8, H M 458005, I/A 27(29.05.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: ZUBILLAGA ISAAC ARMANDO JOSE. Datos registrales. T 35552 , F 43, S 8, H M 458005, I/A 28(29.05.18).

01 de Junio de 2018
Nombramientos. Consejero: ZUBILLAGA ISAAC ARMANDO JOSE. Datos registrales. T 35552 , F 42, S 8, H M 458005, I/A 26(24.05.18).

13 de Abril de 2018
Nombramientos. Con.Delegado: MIRANDA EYZAGUIRRE LUIS FERNANDO. Datos registrales. T 35552 , F 42, S 8, H M 458005,I/A 25 ( 5.04.18).

11 de Abril de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: EMEERRE ASESORES SL. Vicepresid.: EMEERRE ASESORES SL. Con.Delegado: EMEERREASESORES SL. Representan: LOPEZ ALCANTARA ALFREDO. Nombramientos. Consejero: MIRANDA EYZAGUIRRE LUISFERNANDO. Vicepresid.: MIRANDA EYZAGUIRRE LUIS FERNANDO. Datos registrales. T 35552 , F 41, S 8, H M 458005, I/A 24 (3.04.18).

15 de Febrero de 2018
Revocaciones. Apo.Sol.: ORTIZ ROMERO MARIA IZASKUN;NAVARRO DE PALENCIA ZULAICA ANA. Fe de erratas: SEPUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 23陋 LA REVOCACION DEL PODER OTORGADO EN LA INSCRIPCION 4陋 A MOLINALOPEZ MARIA DE LOS MILAGROS Y MILLAN CRUZ MARIA DEL CARMEN, SIENDO LO CORRECTO, NAVARRO DE PALENCIAZULAICA ANA Y ORTIZ ROMERO MARIA IZASKUN. Datos registrales. T 35552 , F 41, S 8, H M 458005, I/A 23 (20.12.17).

02 de Enero de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: ZUBILLAGA ISAAC RAFAEL TEODORO;LLATAS SALVADOR VICENTE. Datos registrales. T 35552 , F40, S 8, H M 458005, I/A 22 (20.12.17).

Revocaciones. Apo.Sol.: MILLAN CRUZ MARIA DEL CARMEN;MOLINA LOPEZ MARIA DE LOS MILAGROS;ANTON HERRERIASCARMEN;ANSON LORENTE MARTA;BEOTAS LOPEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 35552 , F 41, S 8, H M 458005, I/A 23(20.12.17).

09 de Agosto de 2017
Ceses/Dimisiones. Representan: MARTIN-RABADAN MURO MIGUEL. Nombramientos. Representan: LOPEZ ALCANTARAALFREDO. Datos registrales. T 35552 , F 40, S 8, H M 458005, I/A 20 ( 1.08.17).

28 de Febrero de 2017
Cambio de domicilio social. C/ NANCLARES DE OCA 1B (MADRID). Datos registrales. T 25424 , F 107, S 8, H M 458005, I/A 19(20.02.17).

17 de Noviembre de 2016
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 25424 , F 107, S 8, H M 458005,I/A 18 ( 8.11.16).

06 de Noviembre de 2015
Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO VIGESIMOCUARTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datosregistrales. T 25424 , F 107, S 8, H M 458005, I/A 17 (26.10.15).

28 de Enero de 2015
Nombramientos. Apoderado: ZUBILLAGA ISAAC ARMANDO JOSE;ZUBILLAGA REVERON IRENE ANTONIETA;ZUBILLAGAISAAC JOSE MIGUEL;MARTIN-RABADAN MURO MIGUEL. Datos registrales. T 25424 , F 106, S 8, H M 458005, I/A 16 (20.01.15).

31 de Octubre de 2014
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 25424 , F 106, S 8, H M 458005,I/A 15 (22.10.14).

12 de Junio de 2014
Nombramientos. Vicepresid.: EMEERRE ASESORES SL. Con.Delegado: EMEERRE ASESORES SL. Datos registrales. T 25424 ,F 106, S 8, H M 458005, I/A 14 ( 5.06.14).

25 de Febrero de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN RABADAN MURO MIGUEL. Vicepresid.: MARTIN RABADAN MURO MIGUEL.Con.Delegado: MARTIN RABADAN MURO MIGUEL. Nombramientos. Consejero: EMEERRE ASESORES SL. Representan:MARTIN-RABADAN MURO MIGUEL. Datos registrales. T 25424 , F 105, S 8, H M 458005, I/A 13 (18.02.14).

20 de Noviembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ HERRERA GUILLERMO. Datos registrales. T 25424 , F 105, S 8, H M 458005, I/A 12 (6.11.12).

30 de Enero de 2012
Nombramientos. Con.Delegado: MARTIN RABADAN MURO MIGUEL. Datos registrales. T 25424 , F 104, S 8, H M 458005, I/A 9(17.01.12).

Revocaciones. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 25424 , F 104, S 8, H M 458005, I/A 10 (17.01.12).

Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 25424 , F 104, S 8, H M 458005,I/A 11 (18.01.12).

19 de Enero de 2012
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: TAJADURA GARRIDO JOSE MARIA. Nombramientos. SecreNoConsj: SALAMANCA CUEVASMARIA LORENA. Consejero: ZUBILLAGA ISAAC RAFAEL TEODORO. Presidente: ZUBILLAGA ISAAC RAFAEL TEODORO.Consejero: ZUBILLAGA ISAAC BERNARDO JOSE;VAINRUB ACKERMAN ROBERTO;JARDINE HIRD EDWARDDARBYSHIRE;SANCHEZ HERRERA GUILLERMO;LLATAS SALVADOR VICENTE;MONTOYA ALVAREZ JORGEPEREGRINO;MARTIN RABADAN MURO MIGUEL. Vicepresid.: MARTIN RABADAN MURO MIGUEL. Modificaciones estatutarias.Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 25424 , F 103, S 8, HM 458005, I/A 8 ( 9.01.12).

07 de Diciembre de 2010
Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 25424 , F 102, S 8, H M 458005, I/A 7 (25.11.10).

17 de Junio de 2010
Ampliacion del objeto social. LA ADQUISICION, TENENCIA, EXPLOTACION, VENTA Y CESION DE DERECHOS DE PROPIEDADINDUSTRIAL E INTELECTUAL. Cambio de domicilio social. AVDA ARAGON 330 - PARQUE EMPRESARIAL LAS MERCEDES,(MADRID). Datos registrales. T 25424 , F 102, S 8, H M 458005, I/A 6 ( 7.06.10).

16 de Junio de 2010
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ZURITA SAENZ DE NAVARRETE MIGUEL. Nombramientos. Adm. Unico: TAJADURA GARRIDOJOSE MARIA. Datos registrales. T 25424 , F 102, S 8, H M 458005, I/A 5 ( 4.06.10).

04 de Agosto de 2009
Nombramientos. Apo.Sol.: MILLAN CRUZ MARIA DEL CARMEN;MOLINA LOPEZ MARIA DE LOS MILAGROS;ANTONHERRERIAS CARMEN;ANSON LORENTE MARTA;ORTIZ ROMERO MARIA-IZASKUN;NAVARRO DE PALENCIA ZULAICAANA;BEOTAS LOPEZ JOSE LUIS;MULLERAT PRAT RAMON. Datos registrales. T 25424 , F 102, S 8, H M 458005, I/A 4(23.07.09).

28 de Julio de 2009
Modificaciones estatutarias. 22. Administraci贸n y Representacion.-. 27. Cierre del Ejercicio.-. Datos registrales. T 25424 , F 101, S8, H M 458005, I/A 3 (15.07.09).

29 de Mayo de 2009
Cambio de domicilio social. C/ TORRELAGUNA 75 (MADRID). Datos registrales. T 25424 , F 101, S 8, H M 458005, I/A 2(20.05.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n