Buscador CIF Logo

Actos BORME Prestafe Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Prestafe Sl

Actos BORME Prestafe Sl - B85917433

Tenemos registrados 14 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Prestafe Sl con CIF B85917433

馃敊 Perfil de Prestafe Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Prestafe Sl

18 de Enero de 2019
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 36188 , F 186, S 8, H M 497030, I/A 15 (11.01.19).

02 de Enero de 2018
Nombramientos. Apoderado: CALDERON GUZMAN FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 36188 , F 184, S 8, H M 497030,I/A 14 (21.12.17).

20 de Septiembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: MAGDALENA LOPE JOAQUIN;GUILLEN SAEZ RICARDO. Datos registrales. T 27581 , F 163, S 8, HM 497030, I/A 13 (11.09.17).

21 de Agosto de 2017
Revocaciones. Apoderado: RENDON CASTRO MARIA TERESA. Datos registrales. T 27581 , F 163, S 8, H M 497030, I/A 12(11.08.17).

08 de Junio de 2017
Fe de erratas: Se public贸 por error en la Inscripci贸n 8潞 el nombramiento de Apoderado de ARCOS CARGIA JOSE EDUARDO, siendolo correcto ARCOS CARGIA JORGE EDUARDO. Datos registrales. T 27581 , F 160, S 8, H M 497030, I/A 8 (25.08.16).

27 de Febrero de 2017
Revocaciones. Apoderado: USE PERUN FRANCISCO. Datos registrales. T 27581 , F 163, S 8, H M 497030, I/A 11 (17.02.17).

24 de Enero de 2017
Revocaciones. Apoderado: ALBAS GONZALEZ LUIS. Datos registrales. T 27581 , F 163, S 8, H M 497030, I/A 10 (17.01.17).

02 de Diciembre de 2016
Revocaciones. Apoderado: VELASCO TORRES DAVID. Datos registrales. T 27581 , F 163, S 8, H M 497030, I/A 9 (28.11.16).

05 de Septiembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: VALAREZO CASTRO FRANKLIN LENIN;LUNA CAIZATOA PABLO JAVIER;NAVIA CARBO YENNISORAYA;MENDEZ MARQUEZ JACQUELINE;RENDON CASTRO MARIA TERESA;PARADA ROMO LIZ JOHANNA;JACQUELINEESPINOSA MARCELA;GONZALEZ FERNANDEZ ARMANDO JAVIER;VELASCO TORRES DAVID;ALBAS GONZALEZLUIS;ALAMILLO LOPEZ ANA MARIA;ARCOS CARGIA JOSE EDUARDO;MARTINEZ PICAZO EMILIO;ROCA ZAMBRANODIANA;MENDEZ CORRAL ANA ISABEL;MARTINEZ CLEMENTE ANGEL;ELIZABETH CARRION JOHANNA;BUIL ARDANUYVICTOR;CORONEL BUSTAMANTE CECIBEL;CAMACHO SOLIS ABRAHAM;CASTILLO JORGE IGNACIO;FERNANDEZ MARQUEZRUBEN;DEL CAMPO SANZ JUAN DE DIOS;MARCO SANCHEZ CRISTINA;TABUENCA NONEL MARIA-JESUS;FABIA VALLSJESUS;ALONSO DE CASTRO ANGELA;CARRASCAL DOMINGUEZ ANGEL;USE PERUN FRANCISCO;GOMEZ MACIASDAVID;HERRERA NELLY MARCELA;SERRANO ESCUDERO JULIAN;CEPEDA CARRION IGNACIO;CHANCA LARA JORGE;MOYAPE脩AFIEL JUAN CARLOS. Datos registrales. T 27581 , F 160, S 8, H M 497030, I/A 8 (25.08.16).

25 de Noviembre de 2015
Revocaciones. Apoderado: TATO PORTO ANTONIO;ARCOS CARGIA JOSE EDUARDO. Datos registrales. T 27581 , F 160, S 8,H M 497030, I/A 7 (17.11.15).

14 de Octubre de 2015
Ceses/Dimisiones. Representan: GONZALEZ GARCIA JOSE ENRIQUE. Nombramientos. Representan: RUIZ NODAR JORGE.Datos registrales. T 27581 , F 160, S 8, H M 497030, I/A 6 ( 6.10.15).

12 de Noviembre de 2013
Nombramientos. Apoderado: ARCOS CARGIA JOSE EDUARDO. Datos registrales. T 27581 , F 158, S 8, H M 497030, I/A 5 (4.11.13).

27 de Septiembre de 2012
Nombramientos. Apoderado: TATO PORTO ANTONIO. Datos registrales. T 27581 , F 157, S 8, H M 497030, I/A 4 (18.09.12).

14 de Septiembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GONZALEZ GARCIA JOSE ENRIQUE. Nombramientos. Adm. Unico: BANCO PICHINCHAESPA脩A SA. Representan: GONZALEZ GARCIA JOSE ENRIQUE. Cambio de domicilio social. C/ LAGASCA 4 (MADRID). Datosregistrales. T 27581 , F 157, S 8, H M 497030, I/A 3 (29.08.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n