Buscador CIF Logo

Actos BORME Previlabor 365 Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Previlabor 365 Sl

Actos BORME Previlabor 365 Sl - B82509936

Tenemos registrados 39 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Previlabor 365 Sl con CIF B82509936

馃敊 Perfil de Previlabor 365 Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Previlabor 365 Sl

20 de Diciembre de 2023
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: MAS PREVENCION SERVICIO DE PREVENCION SLU. Datosregistrales. T 27989 , F 79, S 8, H M 253053, I/A 56 (13.12.23).

21 de Noviembre de 2023
Revocaciones. Apoderado: RUIZ DE LA SIERRA MARTIN GIL JOSE;TRUJILLO MARTINEZ JOSE-ANTONIO. Datos registrales. T27989 , F 79, S 8, H M 253053, I/A 55 (14.11.23).

02 de Marzo de 2023
Fe de erratas: Se public贸 por error en la inscripci贸n 51陋 el nombramiento de FERRER ECHEVARNE ALFONSO como administradorsolidario, siendo lo correcto ECHEVARNE SANTAMARIA ALFONSO. Datos registrales. T 27989 , F 78, S 8, H M 253053, I/A 51(30.01.23).

Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12. Datos registrales. T 27989 , F 79, S 8, H M 253053, I/A 54(23.02.23).

07 de Febrero de 2023
Nombramientos. Apoderado: RAYON VALPUESTA MARIA LUISA. Datos registrales. T 27989 , F 78, S 8, H M 253053, I/A 53(31.01.23).

06 de Febrero de 2023
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BARUMA SL. Representan: MATJI DE ARROQUIA MARIA DEL PILAR. Nombramientos. Adm.Solid.: FERRER ECHEVARNE ALFONSO;ECHEVARNE SANTAMARIA FERNANDO. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores solidarios. Datos registrales. T 27989 , F 78, S 8, H M 253053, I/A 51(30.01.23).

Nombramientos. Apoderado: SAYOS SUASI RICARDO. Datos registrales. T 27989 , F 78, S 8, H M 253053, I/A 52 (30.01.23).

19 de Enero de 2022
Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/12. Datos registrales. T 27989 , F 77, S 8, H M 253053, I/A 50(12.01.22).

23 de Noviembre de 2021
Reelecciones. Auditor: ABOLL AUDITORES SL. Datos registrales. T 27989 , F 77, S 8, H M 253053, I/A 49 (16.11.21).

10 de Octubre de 2019
Reelecciones. Auditor: ABOLL AUDITORES SL. Datos registrales. T 27989 , F 77, S 8, H M 253053, I/A 48 ( 3.10.19).

21 de Noviembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: MORENO GONZALEZ PILAR. Datos registrales. T 27989 , F 73, S 8, H M 253053, I/A 43 (14.11.18).

Nombramientos. Apoderado: RUIZ DE LA SIERRA MARTIN GIL JOSE. Datos registrales. T 27989 , F 74, S 8, H M 253053, I/A 44(14.11.18).

Nombramientos. Apoderado: CUBEDO RODRIGUEZ CORTEZO MARIA. Datos registrales. T 27989 , F 75, S 8, H M 253053, I/A45 (14.11.18).

Nombramientos. Apoderado: RODRIGO LORITE ISMAEL. Datos registrales. T 27989 , F 76, S 8, H M 253053, I/A 46 (14.11.18).

Nombramientos. Apoderado: TRUJILLO MARTINEZ JOSE-ANTONIO. Datos registrales. T 27989 , F 76, S 8, H M 253053, I/A 47(14.11.18).

26 de Junio de 2015
Reelecciones. Auditor: ABOLL AUDITORES SL. Datos registrales. T 27989 , F 73, S 8, H M 253053, I/A 42 (18.06.15).

26 de Septiembre de 2014
Revocaciones. Apoderado: TRUJILLO MARTINEZ JOSE-ANTONIO;RUIZ DE LA SIERRA MARTIN GIL JOSE;MORENO GONZALEZMARIA DEL PILAR. Apo.Man.Soli: CUBEDO RODRIGUEZ CORTEZO MARIA. Datos registrales. T 27989 , F 73, S 8, H M 253053,I/A 41 (18.09.14).

17 de Junio de 2014
Nombramientos. Apoderado: MORENO GONZALEZ PILAR. Datos registrales. T 27989 , F 72, S 8, H M 253053, I/A 40 (10.06.14).

09 de Junio de 2014
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CUBEDO RODRIGUEZ CORTEZO MARIA. Datos registrales. T 27989 , F 68, S 8, H M 253053, I/A34 (30.05.14).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: RUIZ DE LA SIERRA MARTIN GIL JOSE. Datos registrales. T 27989 , F 68, S 8, H M 253053, I/A35 (30.05.14).

Nombramientos. Apo.Sol.: MATJI DE ARROQUIA JUAN;MATJI DE ARROQUIA CONCEPCION. Datos registrales. T 27989 , F 69,S 8, H M 253053, I/A 36 ( 2.06.14).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ DE NICOLAS MARIA DEL AMPARO. Datos registrales. T 27989 , F 70, S 8, H M253053, I/A 37 ( 2.06.14).

Nombramientos. Apoderado: RODRIGO LORITE ISMAEL. Datos registrales. T 27989 , F 71, S 8, H M 253053, I/A 38 ( 2.06.14).

Nombramientos. Apoderado: GIRON YAGUE MERCEDES. Datos registrales. T 27989 , F 72, S 8, H M 253053, I/A 39 ( 2.06.14).

24 de Diciembre de 2013
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GOMEZ DE SALAZAR MARIA DEL PILAR;ORTIZ MADRAZO MARIA DEL CARMEN. Datosregistrales. T 27989 , F 68, S 8, H M 253053, I/A 33 (17.12.13).

13 de Junio de 2013
Reelecciones. Auditor: ABOLL AUDITORES SL. Datos registrales. T 27989 , F 67, S 8, H M 253053, I/A 32 ( 4.06.13).

27 de Noviembre de 2012
Revocaciones. Apo.Sol.: LLORENS NOE SALVADOR;GONZALEZ GARCIA MARIA-PILAR. Datos registrales. T 27989 , F 67, S 8,H M 253053, I/A 30 (15.11.12).

Revocaciones. Apo.Sol.: CASTILLA REPARAZ JOSE-MARIA. Datos registrales. T 27989 , F 67, S 8, H M 253053, I/A 31(15.11.12).

16 de Abril de 2012
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: BARUMA SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: BARUMA SL;ORTIZ MADRAZOMARIA DEL CARMEN;GOMEZ DE SALAZAR Y DIAZ FAES MARIA DEL PILAR;MATJI DE ARROQUIA PILAR. Presidente: MATJI DEARROQUIA PILAR. Vicepresid.: BARUMA SL. Con.Delegado: MATJI DE ARROQUIA PILAR. Secretario: ARTI脩ANO DEL RIO PABLO.Representan: MATJI DE ARROQUIA CONCEPCION. Nombramientos. Adm. Unico: BARUMA SL. Representan: MATJI DEARROQUIA MARIA DEL PILAR. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 23.100,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros.Ampliaci贸n de capital. Capital: 10.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Cambio delOrgano de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 27989 , F 66, S 8, H M 253053, I/A29 ( 2.04.12).

30 de Noviembre de 2010
Revocaciones. Apo.Man.Soli: RUIZ DE LA SIERRA MARTIN GIL JOSE;MORENO GONZALEZ MARIA DEL PILAR;CUBEDORODRIGUEZ CORTEZO MARIA. Nombramientos. Apoderado: RUIZ DE LA SIERRA MARTIN GIL JOSE. Datos registrales. T27989 , F 64, S 8, H M 253053, I/A 27 (18.11.10).

Nombramientos. Apoderado: MORENO GONZALEZ MARIA DEL PILAR;RUIZ DE LA SIERRA MARTIN GIL JOSE;MATJI DEARROQUIA PILAR;CUBEDO RODRIGUEZ CORTEZO MARIA. Datos registrales. T 27989 , F 64, S 8, H M 253053, I/A 28(18.11.10).

11 de Octubre de 2010
Nombramientos. Apoderado: TRUJILLO MARTINEZ JOSE-ANTONIO. Datos registrales. T 27989 , F 63, S 8, H M 253053, I/A 25(29.09.10).

Revocaciones. Apoderado: URIO RODRIGUEZ SANTIAGO JOSE. Datos registrales. T 27989 , F 64, S 8, H M 253053, I/A 26(29.09.10).

01 de Septiembre de 2010
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ DE SALAZAR MARIA DEL PILAR;ORTIZ MADRAZO MARIA DEL CARMEN. Datosregistrales. T 15140 , F 225, S 8, H M 253053, I/A 19 (19.08.10).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: RUIZ DE LA SIERRA MARTIN GIL JOSE. Datos registrales. T 27989 , F 60, S 8, H M 253053, I/A20 (19.08.10).

Nombramientos. Apo.Sol.: LLORENS NOE SALVADOR. Datos registrales. T 27989 , F 61, S 8, H M 253053, I/A 21 (19.08.10).

Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ GARCIA MARIA-PILAR. Datos registrales. T 27989 , F 62, S 8, H M 253053, I/A 22(19.08.10).

Nombramientos. Apo.Sol.: CASTILLA REPARAZ JOSE-MARIA. Datos registrales. T 27989 , F 62, S 8, H M 253053, I/A 23(19.08.10).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORENO GONZALEZ MARIA DEL PILAR;CUBEDO RODRIGUEZ CORTEZO MARIA. Datosregistrales. T 27989 , F 63, S 8, H M 253053, I/A 24 (19.08.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n