Actos BORME de Prevision Personal Correduria De Seguros Sa
04 de Abril de 2023Cambio de domicilio social. CL TRAVESSERA DE GRACIA NUM.58 PLANTA 3., 3-A (BARCELONA). Datos registrales. T 44982 ,F 179, S 8, H B 16109, I/A 24 (28.03.23).
20 de Mayo de 2022Revocaciones. APODERAD.SOL: CUEZVA FERNANDEZ ANTONIO;CUEZVA FERNANDEZ LIBORIO;CUEZVA JIMENEZALVARO;CUEZVA JIMENEZ JAVIER. Datos registrales. T 44982 , F 178, S 8, H B 16109, I/A 22 (12.05.22).
Nombramientos. APODERAD.SOL: CUEZVA FERNANDEZ ANTONIO;CUEZVA FERNANDEZ LIBORIO;CUEZVA JIMENEZALVARO;CUEZVA JIMENEZ JAVIER. Datos registrales. T 44982 , F 178, S 8, H B 16109, I/A 23 (12.05.22).
11 de Mayo de 2022Fe de erratas: En el BORME no.33/2019 y con referencia 73364 Se rectifica la publicacion en el sentido de que se omitio elnombramiento de CUEZVA JIMENEZ,JAVIER como APODERADO Datos registrales. T 44982 , F 173, S 8, H B 16109, I/A 20 (7.02.19).
28 de Octubre de 2020Modificaciones estatutarias. MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 44982 , F174, S 8, H B 16109, I/A 21 (20.10.20).
18 de Febrero de 2019Fe de erratas: En el BORME no.33/2012 y con referencia 77538 se consigno por error los segundos apellidos de los se脩oresLIBORIO CUEZVA JIMENEZ Y ANTONIO CUEZVA JIMENEZ SIENDO CORRECTO LIBORIO CUEZVA FERNANDEZ Y ANTONIOCUEZVA FERNANDEZ. Datos registrales. T 21070 , F 110, S 8, H B 16109, I/A 13 ( 7.02.12).
Revocaciones. APODERADO: SERRANO PAMPLONA MARIA JOSE. PRESIDENTE: CUEZVA JIMENEZ JAVIER. CONS. DELEG.:CUEZVA JIMENEZ JAVIER. APODERADO: CUEZVA JIMENEZ ALVARO;CUEZVA FERNANDEZ LIBORIO;CUEZVA FERNANDEZANTONIO. SECRETARIO: CUEZVA FERNANDEZ LIBORIO. Nombramientos. CONSEJERO: CUEZVA FERNANDEZANTONIO;CUEZVA FERNANDEZ LIBORIO;CUEZVA HERRERO JORGE;CUEZVA JIMENEZ ALVARO;CUEZVA JIMENEZ JAVIER.SECRETARIO: CUEZVA JIMENEZ ALVARO. PRESIDENTE: CUEZVA JIMENEZ JAVIER. APODERAD.SOL: CUEZVA FERNANDEZANTONIO;CUEZVA FERNANDEZ LIBORIO;CUEZVA JIMENEZ ALVARO. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 209.700,00Euros. Resultante Suscrito: 314.550,00 Euros. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 5: CAMBIO NUMERO, NUMERACION YVALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. Datos registrales. T 44982 , F 173, S 8, H B 16109, I/A 20 ( 7.02.19).
05 de Abril de 2016Revocaciones. SECRETARIO: CUEZVA JIMENEZ ALVARO. Nombramientos. SECRETARIO: CUEZVA FERNANDEZ LIBORIO.Datos registrales. T 44982 , F 172, S 8, H B 16109, I/A 19 (18.03.16).
05 de Noviembre de 2015Revocaciones. CONSEJERO: FERNANDEZ DIAZ LUIS. APODERADO: FERNANDEZ DIAZ LUIS. Nombramientos. CONSEJERO:CUEZVA HERRERO JORGE. Cambio de domicilio social. CL VIA AUGUSTA,48-50 P.6 PTA.4 (BARCELONA). Datos registrales.T 44982 , F 172, S 8, H B 16109, I/A 18 (28.10.15).
01 de Octubre de 2015Nombramientos. AUDIT.CUENT.: FORWARD ECONOMICS SLP. Datos registrales. T 21070 , F 113, S 8, H B 16109, I/A 14(23.09.15).
Revocaciones. AUDIT.CUENT.: FORWARD ECONOMICS SLP. Datos registrales. T 21070 , F 113, S 8, H B 16109, I/A 15(23.09.15).
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.200.000,00 Euros. Desembolsado: 1.200.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.260.101,21 Euros.Resultante Desembolsado: 1.260.101,21 Euros. Datos registrales. T 44982 , F 171, S 8, H B 16109, I/A 16 (23.09.15).
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 735.851,21 Euros. Resultante Suscrito: 524.250,00 Euros. Datos registrales. T 44982 , F171, S 8, H B 16109, I/A 17 (23.09.15).
16 de Febrero de 2012Nombramientos. APODERADO: FERNANDEZ DIAZ LUIS;CUEZVA JIMENEZ ALVARO;CUEZVA JIMENEZ LIBORIO;CUEZVAJIMENEZ ANTONIO. Datos registrales. T 21070 , F 110, S 8, H B 16109, I/A 13 ( 7.02.12).