Buscador CIF Logo

Actos BORME Priburger Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Priburger Sa

Actos BORME Priburger Sa - A81784241

Tenemos registrados 12 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Priburger Sa con CIF A81784241

🔙 Perfil de Priburger Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Priburger Sa

18 de Enero de 2022
Reelecciones. Auditor: ECOAUDIT SLP. Datos registrales. T 34707 , F 106, S 8, H M 196211, I/A 20 (11.01.22).

18 de Marzo de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: ORTIZ CASAS ARTURO. Datos registrales. T 34707 , F 106, S 8, H M 196211, I/A 19 (11.03.21).

19 de Julio de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: VILLANUEVA CASTILLO CARLOS;VILLANUEVA BRAVO FRANCISCO JAVIER. Presidente:VILLANUEVA CASTILLO CARLOS. Secretario: VILLANUEVA BRAVO FRANCISCO JAVIER. Consejero: ORTIZ BETRIANGUILLERMO. Cons.Del.Sol: VILLANUEVA CASTILLO CARLOS;VILLANUEVA BRAVO FRANCISCO JAVIER. Nombramientos.Consejero: ANIMA RECURSOS SL;INVERSIONES FINANCIERAS NUEVO MILENIO SL;ORTIZ BETRIAN GUILLERMO. Presidente:ANIMA RECURSOS SL. Secretario: INVERSIONES FINANCIERAS NUEVO MILENIO SL. Cons.Del.Sol: ANIMA RECURSOSSL;INVERSIONES FINANCIERAS NUEVO MILENIO SL. Representan: VILLANUEVA CASTILLO CARLOS;VILLANUEVA BRAVOFRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 34707 , F 105, S 8, H M 196211, I/A 18 (12.07.19).

25 de Octubre de 2018
Reelecciones. Auditor: ECOAUDIT SLP. Datos registrales. T 34707 , F 105, S 8, H M 196211, I/A 17 (18.10.18).

24 de Octubre de 2018
Reelecciones. Consejero: VILLANUEVA CASTILLO CARLOS;VILLANUEVA BRAVO FRANCISCO JAVIER. Presidente:VILLANUEVA CASTILLO CARLOS. Secretario: VILLANUEVA BRAVO FRANCISCO JAVIER. Consejero: ORTIZ BETRIANGUILLERMO. Cons.Del.Sol: VILLANUEVA CASTILLO CARLOS;VILLANUEVA BRAVO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T34707 , F 104, S 8, H M 196211, I/A 16 (16.10.18).

03 de Abril de 2018
Nombramientos. Apoderado: ORTIZ CASAS GUILLERMO. Datos registrales. T 34707 , F 103, S 8, H M 196211, I/A 15 (23.03.18).

12 de Julio de 2016
Nombramientos. Apoderado: ORTIZ BETRIAN GUILLERMO. Datos registrales. T 12351 , F 178, S 8, H M 196211, I/A 14 (4.07.16).

18 de Enero de 2016
Nombramientos. Auditor: ECOAUDIT SLP. Datos registrales. T 12351 , F 178, S 8, H M 196211, I/A 13 ( 8.01.16).

26 de Junio de 2015
Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 21 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 12351 , F178, S 8, H M 196211, I/A 12 (16.06.15).

24 de Octubre de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: VILLANUEVA BRAVO LUIS IGNACIO. Con.Delegado: VILLANUEVA BRAVO FRANCISCOJAVIER;VILLANUEVA CASTILLO CARLOS;VILLANUEVA BRAVO LUIS IGNACIO. Nombramientos. Consejero: ORTIZ BETRIANGUILLERMO. Cons.Del.Sol: VILLANUEVA CASTILLO CARLOS;VILLANUEVA BRAVO FRANCISCO JAVIER. Reelecciones.Consejero: VILLANUEVA CASTILLO CARLOS;VILLANUEVA BRAVO FRANCISCO JAVIER. Presidente: VILLANUEVA CASTILLOCARLOS. Secretario: VILLANUEVA BRAVO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 12351 , F 177, S 8, H M 196211, I/A 11(15.10.13).

09 de Enero de 2013
Nombramientos. Auditor: ECOAUDIT SLP. Datos registrales. T 12351 , F 177, S 8, H M 196211, I/A 10 (27.12.12).

25 de Enero de 2010
Nombramientos. Auditor: ECOAUDIT SLP. Datos registrales. T 12351 , F 177, S 8, H M 196211, I/A 9 (13.01.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información