Actos BORME de Pricewaterhousecoopers Service Delivery Center -malaga- Sl
13 de Junio de 2023Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 5890, L4797, F 63, S 8, H MA112044, I/A 31 ( 1.06.23).
24 de Febrero de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GOIRIENA BASUALDU I脩AKI. Nombramientos. Adm. Solid.: MUNDORF STEFAN-RUDIGER.Datos registrales. T 5890, L 4797, F 63, S 8, H MA112044, I/A 30 (15.02.23).
13 de Febrero de 2023Reelecciones. Auditor: ZOFIO AUDITORES SL. Datos registrales. T 5890, L 4797, F 62, S 8, H MA112044, I/A 29 ( 2.02.23).
20 de Abril de 2022Reelecciones. Auditor: ZOFIO AUDITORES SL. Datos registrales. T 5890, L 4797, F 62, S 8, H MA112044, I/A 28 ( 7.04.22).
15 de Marzo de 2021Revocaciones. Apoderado: UNSAIN ROMERO SERGIO;CAMPOS CALVO SOTELO MARIA GLORIA;DIAZ DE LA HOZ JESUS;DIAZDE LA HOZ JESUS;DIAZ DE LA HOZ JESUS;DIAZ DE LA HOZ JESUS. Apo.Manc.: URIZARBARRENA BERNARDO JAVIER.Apoderado: REYNOLDS ANTONY CLIFTON. Datos registrales. T 5890, L 4797, F 62, S 8, H MA112044, I/A 27 ( 4.03.21).
04 de Diciembre de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANJURJO POSE GONZALO. Datos registrales. T 5890, L 4797, F 61, S 8, H MA112044, I/A 26(22.11.19).
27 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: TORIBIO RAMOS JESUS. Datos registrales. T 5890, L 4797, F 61, S 8, H MA112044, I/A 25 (18.11.19).
29 de Agosto de 2019Reelecciones. Auditor: ZOFIO AUDITORES SL. Datos registrales. T 5494, L 4401, F 11, S 8, H MA112044, I/A 23 (20.08.19).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ GUERRA PABLO. Datos registrales. T 5494, L 4401, F 11, S 8, H MA112044, I/A 24(20.08.19).
08 de Julio de 2019Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ GUERRA PABLO. Datos registrales. T 5494, L 4401, F 10, S 8, H MA112044, I/A 21(27.06.19).
Revocaciones. Apoderado: BORRALLO PEREZ COCA PAULINO;SANJURJO ALVAREZ MIGUEL. Datos registrales. T 5494, L4401, F 11, S 8, H MA112044, I/A 22 (27.06.19).
05 de Mayo de 2017Revocaciones. Apoderado: PELAEZ GARCIA RICO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 5494, L 4401, F 10, S 8, H MA112044,I/A 20 (25.04.17).
16 de Noviembre de 2016Nombramientos. Apoderado: CALLEJA FERNANDEZ CESAR. Datos registrales. T 5494, L 4401, F 9, S 8, H MA112044, I/A 19 (7.11.16).
23 de Septiembre de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: CUEVA PEROTTI JULIO GERMAN. Datos registrales. T 5494, L 4401, F 9, S 8, H MA112044, I/A 18(15.09.16).
20 de Junio de 2016Revocaciones. Apoderado: MASSO LOPEZ GUILLERMO. Datos registrales. T 5494, L 4401, F 9, S 8, H MA112044, I/A 17(10.06.16).
21 de Abril de 2016Reelecciones. Auditor: ZOFIO AUDITORES SL. Datos registrales. T 4966, L 3873, F 182, S 8, H MA112044, I/A 16 (11.04.16).
17 de Marzo de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: GOIRIENA BASUALDO I脩AKI. Presidente: GOIRIENA BASUALDO I脩AKI. Consejero: NACENTAMARTIN SALVADOR. Con.Delegado: NACENTA MARTIN SALVADOR. Consejero: MORAL ATIENZA ALVARO. Secretario:BORRALLO PEREZ COCA PAULINO. Nombramientos. Adm. Solid.: GOIRIENA BASUALDU I脩AKI;DIAZ LEANTE SANZ PEDROMARCOS. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datosregistrales. T 4966, L 3873, F 182, S 8, H MA112044, I/A 15 ( 9.03.16).
19 de Enero de 2016Revocaciones. Apoderado: VILLALBA GAZEAU LUIS. Datos registrales. T 4966, L 3873, F 181, S 8, H MA112044, I/A 12 (8.01.16).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CUEVA PEROTTI JULIO GERMAN. Datos registrales. T 4966, L 3873, F 181, S 8, H MA112044,I/A 13 ( 8.01.16).
Revocaciones. Apoderado: TORRES GONZALEZ ARANZAZU. Datos registrales. T 4966, L 3873, F 182, S 8, H MA112044, I/A 14 (8.01.16).
17 de Noviembre de 2015Nombramientos. Apoderado: GOIRIENA BASUALDO I脩AKI. Datos registrales. T 4966, L 3873, F 180, S 8, H MA112044, I/A 11 (6.11.15).
07 de Abril de 2015Revocaciones. Apoderado: ZORRILLA TORRAS NATALIA. Datos registrales. T 4966, L 3873, F 180, S 8, H MA112044, I/A 10(25.03.15).
24 de Diciembre de 2013Revocaciones. Apoderado: VALLS MORATO MANUEL. Datos registrales. T 4966, L 3873, F 179, S 8, H MA112044, I/A 9(13.12.13).
30 de Abril de 2013Nombramientos. Apoderado: TORRES GONZALEZ ARANZAZU. Datos registrales. T 4966, L 3873, F 179, S 8, H MA112044, I/A 8(18.04.13).
11 de Marzo de 2013Nombramientos. Auditor: ZOFIO AUDITORES SL. Datos registrales. T 4966, L 3873, F 179, S 8, H MA112044, I/A 7 ( 1.03.13).
06 de Febrero de 2013Revocaciones. Apoderado: GUTIERREZ RODRIGUEZ YOLANDA;LOPEZ OTAOLA JAVIER. Datos registrales. T 4966, L 3873, F179, S 8, H MA112044, I/A 6 (28.01.13).
26 de Noviembre de 2012Cambio de domicilio social. AVDA SEVERO OCHOA 16-20 BAJA - EDF. NERJA, PARQUE (MALAGA). Datos registrales. T 4966,L 3873, F 179, S 8, H MA112044, I/A 5 (12.11.12).
24 de Febrero de 2012Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: LATORRE TAMBO JOAQUIN;ALAMAN CALABUIG MARTA. Nombramientos. Secretario:BORRALLO PEREZ COCA PAULINO. Consejero: GOIRIENA BASUALDO I脩AKI. Presidente: GOIRIENA BASUALDO I脩AKI.Consejero: NACENTA MARTIN SALVADOR. Con.Delegado: NACENTA MARTIN SALVADOR. Consejero: MORAL ATIENZAALVARO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejo deadministraci贸n. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto.-. Cambio de objeto social. La organizaci贸n, planificaci贸n y realizaci贸n de tareasadministrativas de naturaleza b谩sica, tales como tramitar correspondencia y su control de entrada y salida, recepci贸n y clasificaci贸n dedocumentos, archivo, custodia dedocumentos investigaci贸n y busqueda de informaci贸n de mercados. Datos registrales. T 4966, L3873, F 178, S 8, H MA112044, I/A 4 (10.02.12).
13 de Febrero de 2012Revocaciones. Apoderado: IBA脩EZ LUCEA MAXIMO. Datos registrales. T 4966, L 3873, F 178, S 8, H MA112044, I/A 3 (31.01.12).