Actos BORME de Priesca Sl
16 de Noviembre de 2023Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3510 , F 95, S 8, H MU 35689, I/A35 ( 8.11.23).
Otros conceptos: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 6, 7, 10, 12, 13, 16, 17 Y 18 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datosregistrales. T 3510 , F 96, S 8, H MU 35689, I/A 36 ( 9.11.23).
03 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: ALBERTO PEREZ FONTAN FERNANDEZ;LUIS RAUL RODRIGUEZ COJO. Datos registrales. T 3510 ,F 95, S 8, H MU 35689, I/A 34 (26.10.23).
13 de Septiembre de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: IGOR ALBIOL GUTIERREZ;LUIS JAVIER PEREZ CAMPO. Nombramientos. Apo.Sol.: SANTIAGODELGADO GARCIA;ALVARO UNTORIA OCHOVO. Datos registrales. T 3510 , F 94, S 8, H MU 35689, I/A 33 ( 6.09.23).
22 de Mayo de 2023Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: DAVID LOPEZ MEDINA. Nombramientos. SecreNoConsj: ALBERTO PEREZ FONTANFERNANDEZ. VsecrNoConsj: DAVID LOPEZ MEDINA. Datos registrales. T 3510 , F 93, S 8, H MU 35689, I/A 31 (15.05.23).
Nombramientos. Apoderado: ALBERTO PEREZ FONTAN FERNANDEZ. Datos registrales. T 3510 , F 93, S 8, H MU 35689, I/A 32(15.05.23).
15 de Diciembre de 2022Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3510 , F 93, S 8, H MU 35689, I/A30 ( 7.12.22).
19 de Octubre de 2022Revocaciones. Apoderado: JOSE ANTONIO FERNANDEZ DIEZ;FELIX VILLAVERDE CARNEVALI. Datos registrales. T 3510 , F93, S 8, H MU 35689, I/A 29 (11.10.22).
16 de Diciembre de 2021Revocaciones. Apoderado: OLIVIER RENE GOMEZ PAUMAR. Datos registrales. T 3510 , F 93, S 8, H MU 35689, I/A 28(10.12.21).
18 de Mayo de 2021Nombramientos. Apoderado: OLIVIER RENE GOMEZ PAUMAR. Datos registrales. T 3437 , F 6, S 8, H MU 35689, I/A 25(11.05.21).
Revocaciones. Apoderado: MARIO GRANADO GUIJARRO. Datos registrales. T 3437 , F 7, S 8, H MU 35689, I/A 26 (11.05.21).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: JOSE RAMON ROMERO RUIZ-GIMENEZ. Nombramientos. Apo.Sol.: IGOR ALBIOLGUTIERREZ;LUIS JAVIER PEREZ CAMPO. Datos registrales. T 3437 , F 7, S 8, H MU 35689, I/A 27 (11.05.21).
26 de Octubre de 2020Nombramientos. Apoderado: LUCIANO JOSE GARCIA CARRION CORUJO. Datos registrales. T 3437 , F 6, S 8, H MU 35689, I/A24 (19.10.20).
13 de Julio de 2020Revocaciones. Apoderado: RAMON CALABIA DEL CAMPO. Nombramientos. Apoderado: MARIO GRANADO GUIJARRO. Datosregistrales. T 3437 , F 6, S 8, H MU 35689, I/A 23 ( 6.07.20).
09 de Marzo de 2020Nombramientos. Vicepresid.: LUCIANO JOSE GARCIA CARRION CORUJO. Datos registrales. T 3437 , F 6, S 8, H MU 35689, I/A22 (26.02.20).
03 de Febrero de 2020Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 2840 , F 97, S 8, H MU 35689, I/A 21 (27.01.20).
10 de Enero de 2020Ceses/Dimisiones. Secretario: RAFAELA CORUJO DIAZ. Vicesecret.: LUCIANO JOSE GARCIA CARRION CORUJO.Revocaciones. Apoderado: JUAN VALERO MORENO;FELIX VILLAVERDE CARNEVALI. Nombramientos. Apo.Man.Soli: JOSEGARCIA CARRION JORDAN;MARIA-RAFAELA CORUJO DIAZ;LUCIANO JOSE GARCIA CARRION CORUJO;DAVID LOPEZMEDINA;JOSE RAMON ROMERO RUIZ-GIMENEZ. SecreNoConsj: DAVID LOPEZ MEDINA. Datos registrales. T 2840 , F 95, S 8, HMU 35689, I/A 19 ( 2.01.20).
Nombramientos. Apoderado: RAMON CALABIA DEL CAMPO. Datos registrales. T 2840 , F 97, S 8, H MU 35689, I/A 20 ( 2.01.20).
26 de Septiembre de 2017Otros conceptos: Modificada la letra del CIF de la sociedad de esta hoja, que es B03063252, a instancia de Don José García CarriónJordán, en unión de tarjeta del CIF. Datos registrales. T 1718 , F 100, S 8, H MU 35689, I/A 3 a (19.09.17).
17 de Marzo de 2017Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2840 , F 95, S 8, H MU 35689, I/A 18 (10.03.17).