Buscador CIF Logo

Actos BORME Prim Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Prim Sa

Actos BORME Prim Sa - A28165587

Tenemos registrados 128 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Prim Sa con CIF A28165587

馃敊 Perfil de Prim Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Prim Sa

20 de Diciembre de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: MENDES CASTRO ANTONIO FRANCISCO. Apoderado: PRIM MARTINEZ JORGE. Datos registrales. T43030 , F 15, S 8, H M 61451, I/A 284 (13.12.23).

15 de Junio de 2023
Otros conceptos: MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN CUANTO A LA REDACCIONACTUAL DE LOS ARTICULOS 5, 5.bis, 8, 9, 25 Y 27. Datos registrales. T 43030 , F 12, S 8, H M 61451, I/A 281 ( 8.06.23).

01 de Junio de 2023
Ceses/Dimisiones. Consj.Domini: PRIM MARTINEZ IGNACIO. Nombramientos. Consj.Domini: GONZALEZ PRIM JUAN JESUS.Datos registrales. T 43030 , F 12, S 8, H M 61451, I/A 280 (25.05.23).

12 de Mayo de 2023
Otros conceptos: Subsanaci贸n de la inscripci贸n 276陋 en cuanto al capital social en el art. 9潞. Datos registrales. T 43030 , F 11, S 8,H M 61451, I/A 279 ( 5.05.23).

03 de Mayo de 2023
Revocaciones. Apoderado: ESTAIRE PRIM ANDRES. Datos registrales. T 43030 , F 11, S 8, H M 61451, I/A 278 (24.04.23).

27 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apoderado: ESTAIRE PRIM ANDRES. Datos registrales. T 43030 , F 11, S 8, H M 61451, I/A 277 (20.03.23).

15 de Marzo de 2023
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 19.221,75 Euros. Resultante Suscrito: 4.259.144,50 Euros. Modificaciones estatutarias.9. Capital social.. 10. Acciones . Datos registrales. T 43030 , F 10, S 8, H M 61451, I/A 276 ( 8.03.23).

07 de Noviembre de 2022
Nombramientos. Vicesecret.: POZO LOZANO LUIS. Datos registrales. T 43030 , F 9, S 8, H M 61451, I/A 275 (28.10.22).

28 de Septiembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: GIMENEZ REYNA RODRIGUEZ ENRIQUE;ARRAEZ BERTOLIN IGNACIO. Vicesecret.: ARRAEZBERTOLIN IGNACIO. Vicepr.2: GIMENEZ REYNA RODRIGUEZ ENRIQUE. Nombramientos. Con.Ind.: GALLARDO MATEOMAR;LARA SANZ MARIO;VI脩AS PICH MIGUEL. Datos registrales. T 43030 , F 8, S 8, H M 61451, I/A 273 (21.09.22).

Modificaciones estatutarias. Modificado el art. 29 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 43030 , F 9, S 8, H M 61451, I/A274 (21.09.22).

25 de Marzo de 2022
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 58.414,75 Euros. Resultante Suscrito: 4.278.366,25 Euros. Modificaciones estatutarias.Se modifica el articulo 9 y el apartado 1 del articulo 10. Datos registrales. T 43030 , F 7, S 8, H M 61451, I/A 272 (19.03.22).

22 de Marzo de 2022
Nombramientos. Apoderado: ORTIZ DE ZARATE ROBERTO. Datos registrales. T 43030 , F 6, S 8, H M 61451, I/A 271 (15.03.22).

07 de Marzo de 2022
Otros conceptos: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 8, 15, 15 BIS, 16, 20 BIS, Y 23 DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA. Datosregistrales. T 43030 , F 4, S 8, H M 61451, I/A 269 (28.02.22).

Revocaciones. Apoderado: GARCIA CORTES FRANCISCO;GARCIA CORTES FRANCISCO;ROMAN GIL YOLANDA.Nombramientos. Apo.Man.Soli: OLIVEROS ARREAGA LUIS FERNANDO;BORRAS CASES HELENA;ROMAN GIL YOLANDA.Datos registrales. T 43030 , F 6, S 8, H M 61451, I/A 270 (28.02.22).

04 de Febrero de 2022
Modificaciones estatutarias. modificaci贸n apartado 2 del articulo 3, apartado 2 del 74, modificaci贸n art 59 a 63, modificaci贸napartados 1 y 3 art 70 y 71, modificaci贸n apartado 4 del art 74, adici贸n art 76 bis, adici贸n apartado 3 art 82, adici贸n apartado 3 art 98,modificaci贸n art 103, supresi贸n art 111, 112, 110. modificacion. Datos registrales. T 40763 , F 159, S 8, H M 61451, I/A 268(28.01.22).

31 de Enero de 2022
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 40763 , F 158, S 8, H M61451, I/A 267 (24.01.22).

23 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ HERRERO DAVID. Datos registrales. T 40763 , F 158, S 8, H M 61451, I/A 266(16.12.21).

13 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: OLIVEROS ARREAGA LUIS FERNANDO. Datos registrales. T 40763 , F 157, S 8, H M 61451, I/A265 ( 2.12.21).

26 de Noviembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: JUAREZ VILLAMOR MARIA INMACULADA. Datos registrales. T 40763 , F 157, S 8, H M 61451, I/A264 (19.11.21).

29 de Septiembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: ALONSO DREGI RAFAEL. Datos registrales. T 40763 , F 157, S 8, H M 61451, I/A 263 (22.09.21).

06 de Mayo de 2021
Nombramientos. Apoderado: IRIONDO ARRIOLA ALBERTO. Datos registrales. T 40763 , F 152, S 8, H M 61451, I/A 260(28.04.21).

Nombramientos. Apoderado: OLIVEROS ARREAGA LUIS FERNANDO. Datos registrales. T 40763 , F 154, S 8, H M 61451, I/A261 (28.04.21).

Revocaciones. Apoderado: DEZA ANTA MARIA ESPERANZA. Apo.Sol.: DEZA ANTA ESPERANZA;VICENTE HERNANDOALEJANDRO;IRIONDO ARRIOLA ALBERTO. Apoderado: DEZA ANTA ESPERANZA;IRIONDO ARRIOLA ALBERTO;PRIMMARTINEZ JORGE;IRIONDO ARRIOLA ALBERTO. Datos registrales. T 40763 , F 156, S 8, H M 61451, I/A 262 (28.04.21).

26 de Marzo de 2021
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 3. Domicilio social . Cambio de domicilio social. AVDA DEL LLANOCASTELLANO 43 - PLANTA 3 -FUENCARRA (MADRID). Datos registrales. T 40763 , F 152, S 8, H M 61451, I/A 259 (19.03.21).

17 de Diciembre de 2020
Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS Y REFUNDIDOS LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 40763 , F 143,S 8, H M 61451, I/A 256 (10.12.20).

Otros conceptos: SE MODIFICA EL APARTADO 1 DEL ARTICULO 19 DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL Y SEINCORPORA EN DICHO REGLAMENTO EL ARTICULO 20BIS. Datos registrales. T 40763 , F 151, S 8, H M 61451, I/A 257(10.12.20).

Nombramientos. Consj.Domini: GARCIA BECERRIL MARIA ELENA;PRIM MARTINEZ IGNACIO;GUISASOLA MASAVEU

30 de Octubre de 2020
Otros conceptos: QUEDA MODIFICADO EL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Datos registrales. T 37673 ,F 48, S 8, H M 61451, I/A 255 (25.10.20).

18 de Agosto de 2020
Ceses/Dimisiones. Consj.Domini: LA FUENTE SALADA SL. Cons.Ejecuti: ESTAIRE ALVAREZ ANDRES. Presidente: ESTAIREALVAREZ ANDRES. Representan: COMENGE VALENCIA LUCIA MARIA. Revocaciones. Apoderado: ESTAIRE ALVAREZANDRES;ESTAIRE ALVAREZ ANDRES. Apo.Sol.: ESTAIRE ALVAREZ ANDRES. Apoderado: ESTAIRE ALVAREZ ANDRES.Nombramientos. Consj.Domini: COMENGE VALENCIA LUCIA MARIA. Vicepr.1: PRIM MARTINEZ JORGE. Presidente: COMENGEVALENCIA LUCIA MARIA. Datos registrales. T 37673 , F 47, S 8, H M 61451, I/A 254 (11.08.20).

29 de Julio de 2020
Nombramientos. Apoderado: MARTIN MENENDEZ MONICA;SOMOZA SAEZ CARMEN. Datos registrales. T 37673 , F 44, S 8, HM 61451, I/A 249 (22.07.20).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA CORTES FRANCISCO;ROMAN GIL YOLANDA. Datos registrales. T 37673 , F 45, S 8, H M61451, I/A 250 (22.07.20).

Nombramientos. Apoderado: PEREZ GIL DELGADO ALVARO;ESTAIRE PRIM ANDRES;OLEA VALLEJO MIGUELANGEL;VELASCO IGLESIAS CARLOS;LOPEZ SEBASTIAN MERELLO PATRICIO;GONZALEZ SANCHEZ IGNACIO. Datosregistrales. T 37673 , F 45, S 8, H M 61451, I/A 251 (22.07.20).

Revocaciones. Apoderado: OSORIO PORRAS JOSE LUIS;RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS JOSE;VICENTE HERNANDOALEJANDRO;RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS JOSE;MEIJIDE GARCIA JOSE LUIS;RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS JOSE;TARINGARCIA SALVADOR;RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS JOSE;MEIJIDE GARCIA JOSE LUIS;FERNANDEZ FLORES FUNESFRANCISCO. Apo.Sol.: VICENTE HERNANDO ALEJANDRO. Datos registrales. T 37673 , F 46, S 8, H M 61451, I/A 252 (22.07.20).

Revocaciones. Apoderado: MEJIDE GARCIA JOSE LUIS. Datos registrales. T 37673 , F 46, S 8, H M 61451, I/A 253 (22.07.20).

28 de Julio de 2020
Nombramientos. Apoderado: PRIM MARTINEZ JORGE;IRIONDO ARRIOLA ALBERTO. Datos registrales. T 37673 , F 42, S 8, H M61451, I/A 247 (21.07.20).

Nombramientos. Apoderado: COMENGE VALENCIA LUCIA MARIA;PRIM MARTINEZ JORGE;IRIONDO ARRIOLA ALBERTO.Datos registrales. T 37673 , F 44, S 8, H M 61451, I/A 248 (21.07.20).

18 de Junio de 2020
Nombramientos. Apoderado: IRIONDO ARRIOLA ALBERTO. Datos registrales. T 37673 , F 40, S 8, H M 61451, I/A 245 (11.06.20).

Nombramientos. Consj.Domini: POZO LOZANO LUIS. Datos registrales. T 37673 , F 41, S 8, H M 61451, I/A 246 (11.06.20).

14 de Mayo de 2020
Nombramientos. Apoderado: PRIM MARTINEZ JORGE. Datos registrales. T 37673 , F 40, S 8, H M 61451, I/A 244 ( 7.05.20).

30 de Marzo de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: MEIJIDE GARCIA JOSE LUIS. Vicepr.1: MEIJIDE GARCIA JOSE LUIS. Datos registrales. T 37673 ,F 39, S 8, H M 61451, I/A 243 (23.03.20).

09 de Octubre de 2019
Ceses/Dimisiones. Representan: COMENGE SANCHEZ-REAL JOSE IGNACIO. Nombramientos. Representan: COMENGEVALENCIA LUCIA MARIA. Datos registrales. T 37673 , F 39, S 8, H M 61451, I/A 242 ( 2.10.19).

23 de Julio de 2019
Reelecciones. Consj.Domini: PRIM MARTINEZ JORGE. Datos registrales. T 37673 , F 38, S 8, H M 61451, I/A 240 (16.07.19).

Reelecciones. Consejero: MEIJIDE GARCIA JOSE LUIS. Datos registrales. T 37673 , F 39, S 8, H M 61451, I/A 241 (16.07.19).

26 de Junio de 2019
Otros conceptos: Practicado el deposito de Pactos Parasociales de la sociedad PRIM SA conforme al Art. 531 LSC.- Datosregistrales. T 3652 , F 4, S 8, H M 61451, I/A 36-M (19.06.19).

21 de Febrero de 2019
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: ANOTA SA. Datos registrales. T 37673 , F 37, S 8, H M 61451, I/A 239 (14.02.19).

18 de Enero de 2019
Cambio de domicilio social. C/ YOLANDA GONZALEZ, NUMERO 15, POLIGONO INDUSTRIA (MOSTOLES). Datos registrales. T37673 , F 37, S 8, H M 61451, I/A 238 (11.01.19).

28 de Noviembre de 2018
Nombramientos. Consj.Domini: PRIM MARTINEZ JORGE. Datos registrales. T 37673 , F 36, S 8, H M 61451, I/A 237 (21.11.18).

10 de Octubre de 2018
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 37673 , F 36, S 8, H M61451, I/A 236 ( 1.10.18).

28 de Septiembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Presidente: PRIM GONZALEZ VICTORIANO. Consejero: PRIM GONZALEZ VICTORIANO. Vicepresid.: ESTAIREALVAREZ ANDRES. Nombramientos. Presidente: ESTAIRE ALVAREZ ANDRES. Vicepr.2: GIMENEZ REYNA RODRIGUEZENRIQUE. Vicepr.1: MEIJIDE GARCIA JOSE LUIS. Datos registrales. T 37673 , F 35, S 8, H M 61451, I/A 234 (20.09.18).

Revocaciones. Apoderado: PRIM GONZALEZ VICTORIANO;PRIM GONZALEZ VICTORIANO;PRIM GONZALEZVICTORIANO;PRIM GONZALEZ VICTORIANO. Apo.Sol.: PRIM GONZALEZ VICTORIANO. Datos registrales. T 37673 , F 36, S 8, HM 61451, I/A 235 (20.09.18).

24 de Septiembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: DEZA ANTA ESPERANZA. Datos registrales. T 37673 , F 34, S 8, H M 61451, I/A 233 (17.09.18).

07 de Agosto de 2018
Nombramientos. Apoderado: ESTAIRE ALVAREZ ANDRES. Datos registrales. T 37673 , F 33, S 8, H M 61451, I/A 231 (27.07.18).

Nombramientos. Apoderado: PRIM MARTINEZ JORGE. Datos registrales. T 37673 , F 33, S 8, H M 61451, I/A 232 (27.07.18).

01 de Agosto de 2018
Otros conceptos: RATIFICADO EL NOMBRAMIENTO POR COOPTACION DE DON ANDRES ESTAIRE ALVAREZ COMOCONSEJERO EJECUTIVO Y VICEPRESIDENTE. Datos registrales. T 37673 , F 31, S 8, H M 61451, I/A 225 (24.07.18).

Reelecciones. Consejero: GIMENEZ REYNA RODRIGUEZ ENRIQUE;ARRAEZ BERTOLIN IGNACIO. Vicesecret.: ARRAEZBERTOLIN IGNACIO. Datos registrales. T 37673 , F 31, S 8, H M 61451, I/A 226 (24.07.18).

Nombramientos. Consj.Domini: LA FUENTE SALADA SL. Representan: COMENGE SANCHEZ-REAL JOSE IGNACIO. Datosregistrales. T 37673 , F 32, S 8, H M 61451, I/A 228 (24.07.18).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ SANCHEZ IGNACIO. Datos registrales. T 37673 , F 33, S 8, H M 61451, I/A 229(24.07.18).

Nombramientos. Apoderado: OLEA VALLEJO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 37673 , F 33, S 8, H M 61451, I/A 230(24.07.18).

06 de Junio de 2018
Otros conceptos: El proyecto de fusi贸n ha quedado depositadocon fecha 11 de mayo de 2018 en el siguiente enlace de la paginaweb de la sociedad www.prim.es/index.php. Datos registrales. T 3652 , F 1, S 8, H M 61451, I/A 36 M (30.05.18).

05 de Junio de 2018
Revocaciones. Apoderado: SERRA BALA脩A EULALIA. Datos registrales. T 28858 , F 199, S 8, H M 61451, I/A 222 (28.05.18).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ SANCHEZ IGNACIO. Datos registrales. T 28858 , F 199, S 8, H M 61451, I/A 223(28.05.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: IRIONDO ARRIOLA ALBERTO;VICENTE HERNANDO ALEJANDRO. Datos registrales. T 28858 , F199, S 8, H M 61451, I/A 224 (28.05.18).

01 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apoderado: ESTAIRE PRIM ANDRES. Datos registrales. T 28858 , F 198, S 8, H M 61451, I/A 221 (25.01.18).

30 de Enero de 2018
Otros conceptos: LA ENTIDAD "PRIM SA", ABSORBE A LA ENTIDAD DOMICILIADA EN MOSTOLES DENOMINADA " ENRAFNONIUS IBERICA SA ".- Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: ENRAF NONIUS IBERICA SA. Datos registrales. T28858 , F 196, S 8, H M 61451, I/A 220 (16.01.18).

25 de Agosto de 2017
Revocaciones. Apoderado: CHINCHILLA DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL;CHINCHILLA DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL;CHINCHILLADOMINGUEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 28858 , F 196, S 8, H M 61451, I/A 219 (17.08.17).

01 de Agosto de 2017
Ceses/Dimisiones. Consj.Domini: BARTAL INVERSIONES SL. Representan: ESTAIRE ALVAREZ ANDRES. Vicepresid.: BARTALINVERSIONES SL. Nombramientos. Cons.Ejecuti: ESTAIRE ALVAREZ ANDRES. Vicepresid.: ESTAIRE ALVAREZ ANDRES.Datos registrales. T 28858 , F 196, S 8, H M 61451, I/A 218 (21.07.17).

25 de Mayo de 2017
Otros conceptos: El d铆a 12 de Mayo de 2017 ha quedado publicado en la p谩gina web de "PRIM SA" (Sociedad Absorbente),"www.prim.es/index.php", y de "ENRAF NONIUS IBERICA SA" (Sociedad Absorbida), "www.enraf.es", el Proyecto Com煤n de Fusi贸nde dichas Sociedades. Datos registrales. T 3652 , F 3, S 8, H M 61451, I/A 36M (18.05.17).

03 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: PAJUELO DIAZ ROSA. Datos registrales. T 28858 , F 195, S 8, H M 61451, I/A 217 (24.10.16).

05 de Octubre de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: BARTAL INVERSIONES SL. Nombramientos. Consj.Domini: BARTAL INVERSIONES SL.Reelecciones. Vicepresid.: BARTAL INVERSIONES SL. Otros conceptos: Ratificaci贸n del nombramiento de D陋 Belen Amatriain

27 de Enero de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ DE MENDEZONA JUAN JOSE. Nombramientos. Con.Ind.: AMATRIAIN CORBI BELEN.

19 de Enero de 2016
Otros conceptos: DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 233.2 RRM, NO SE EXPIDE LA CERTIFICACION QUE PRECEPTUADICHO ARTICULO POR NO EXISTIR ASIENTOS QUE HAYAN DE QUEDAR VIGENTES PARA SU INCORPORACION A ESTEREGISTRO.- Datos registrales. T 28858 , F 192, S 8, H M 61451, I/A214/M (11.01.16).

13 de Noviembre de 2015
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: LUGA SUMINISTROS MEDICOS SL. Datos registrales. T 28858 , F 192, S 8, H M61451, I/A 214 ( 3.11.15).

20 de Octubre de 2015
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 28858 , F 191, S 8, H M61451, I/A 213 ( 8.10.15).

10 de Agosto de 2015
Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS Y REFUNDIDOS LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 28858 , F 176,S 8, H M 61451, I/A 209 (30.07.15).

Otros conceptos: MODIFICADO EL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. Datos registrales. T 28858 , F183, S 8, H M 61451, I/A 210 (30.07.15).

Otros conceptos: MODIFICADO EL REGLAMENTO DEL CONSEJO. Datos registrales. T 28858 , F 188, S 8, H M 61451, I/A 211(30.07.15).

25 de Mayo de 2015
Otros conceptos: INSERCION EN LA PAGINA WEB "HTTP://WWW.PRIM.ES/INDEX.PHP. EL PROYECTO DE FUSION ENTREPRIM SA COMO ABSOBENTE Y LUGA SUMINISTROS MEDICOS SL COMO ABSORBIDA. Datos registrales. T 3652 , F 3, S 8, HM 61451, I/A 36-M (21.05.15).

20 de Mayo de 2015
Ceses/Dimisiones. Secretario: ARRAEZ BERTOLIN IGNACIO. Vicesecret.: MEIJIDE GARCIA JOSE LUIS. Nombramientos.SecreNoConsj: ALONSO DREGI RAFAEL. Vicesecret.: ARRAEZ BERTOLIN IGNACIO. Datos registrales. T 28858 , F 175, S 8, H M61451, I/A 208 ( 8.05.15).

05 de Enero de 2015
Revocaciones. Apoderado: MEIJIDE GARCIA JOSE LUIS;MEIJIDE GARCIA JOSE LUIS. Datos registrales. T 28858 , F 175, S 8, HM 61451, I/A 207 (23.12.14).

30 de Septiembre de 2014
Nombramientos. Apo.Sol.: ESTAIRE ALVAREZ ANDRES;PRIM GONZALEZ VICTORIANO. Datos registrales. T 28858 , F 174, S 8,H M 61451, I/A 206 (22.09.14).

04 de Septiembre de 2014
Reelecciones. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SL. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 28858 , F 174, S 8, H M61451, I/A 205 (28.08.14).

01 de Agosto de 2014
Modificaciones estatutarias. 24. Funcionamiento Junta Gral.-. Datos registrales. T 28858 , F 173, S 8, H M 61451, I/A 204(25.07.14).

29 de Julio de 2014
Reelecciones. Presidente: PRIM GONZALEZ VICTORIANO. Consejero: PRIM GONZALEZ VICTORIANO. Datos registrales. T28858 , F 173, S 8, H M 61451, I/A 203 (21.07.14).

04 de Junio de 2014
Revocaciones. Apoderado: MENDES CASTRO ANTONIO FRANCISCO. Nombramientos. Apo.Sol.: MENDES CASTRO ANTONIOFRANCISCO. Datos registrales. T 28858 , F 172, S 8, H M 61451, I/A 202 (28.05.14).

10 de Abril de 2014
Otros conceptos: MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO AL OBJETO DE ADAPTARLO A LAS MODIFICACIONES

31 de Enero de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ PRIM ANDRES-MARIA. Datos registrales. T 28858 , F 170, S 8, H M 61451, I/A 200(23.01.14).

20 de Enero de 2014
Revocaciones. Apoderado: ZAMORA RUIZ FELIX FRANCISCO;ZAMORA RUIZ FELIX FRANCISCO. Datos registrales. T 28858 , F169, S 8, H M 61451, I/A 199 ( 9.01.14).

21 de Noviembre de 2013
Nombramientos. Apoderado: MENDES CASTRO ANTONIO FRANCISCO. Datos registrales. T 28858 , F 169, S 8, H M 61451, I/A198 (13.11.13).

12 de Agosto de 2013
Reelecciones. Consejero: MEIJIDE GARCIA JOSE LUIS. Vicesecret.: MEIJIDE GARCIA JOSE LUIS. Datos registrales. T 28858 , F169, S 8, H M 61451, I/A 196 ( 1.08.13).

Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 24潞. Datos registrales. T 28858 , F 169, S 8, H M 61451, I/A 197 (1.08.13).

19 de Julio de 2013
Revocaciones. Apoderado: GOMEZ PARRILLA JOSE LUIS. Datos registrales. T 28858 , F 168, S 8, H M 61451, I/A 194 (12.07.13).

Revocaciones. Apoderado: GASPAR BLANCO FEDERICO. Datos registrales. T 28858 , F 168, S 8, H M 61451, I/A 195 (12.07.13).

16 de Julio de 2013
Nombramientos. Apoderado: PRIM GONZALEZ VICTORIANO. Datos registrales. T 28858 , F 168, S 8, H M 61451, I/A 193 (8.07.13).

10 de Julio de 2013
Nombramientos. Secretario: ARRAEZ BERTOLIN IGNACIO. Otros conceptos: Se omiti贸 el nombramiento de Don Ignacio ArraezBertolin como Secretario del Consejo de Administraci贸n en la inscripci贸n189 practicada con fecha 14 de Noviembre de 2012.- Datosregistrales. T 28858 , F 167, S 8, H M 61451, I/A 192 ( 3.07.13).

27 de Marzo de 2013
Revocaciones. Apoderado: LEON PERERA CRISTOBALINA. Datos registrales. T 28858 , F 167, S 8, H M 61451, I/A 191(19.03.13).

12 de Febrero de 2013
Nombramientos. Apoderado: SANTANA PEREZ MONICA. Datos registrales. T 28858 , F 167, S 8, H M 61451, I/A 190 ( 4.02.13).

03 de Diciembre de 2012
Otros conceptos: RATIFICADO EL NOMBRAMIENTO EFECTUADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION PORCOOPTACION MEDIANTE ESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION 186& DE LA HOJA SOCIAL DE DON ENRIQUE GIMENEZ-REYNARODRIGUEZ. Datos registrales. T 28858 , F 166, S 8, H M 61451, I/A 188 (14.11.12).

Otros conceptos: RATIFICADO EL NOMBRAMIENTO EFECTUADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION PORCOOPTACION MEDIANTE ESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION 187& DE LA HOJA SOCIAL DE DON IGNACIO ARRAEZBERTOLIN. Datos registrales. T 28858 , F 166, S 8, H M 61451, I/A 189 (14.11.12).

08 de Noviembre de 2012
Nombramientos. Consejero: GIMENEZ REYNA RODRIGUEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 28858 , F 165, S 8, H M 61451, I/A186 (26.10.12).

Nombramientos. Consejero: ARRAEZ BERTOLIN IGNACIO. Datos registrales. T 28858 , F 166, S 8, H M 61451, I/A 187(26.10.12).

22 de Agosto de 2012
Nombramientos. Apoderado: PRIM GONZALEZ VICTORIANO. Datos registrales. T 28858 , F 162, S 8, H M 61451, I/A 184 (8.08.12).

Nombramientos. Apoderado: ESTAIRE ALVAREZ ANDRES. Datos registrales. T 28858 , F 162, S 8, H M 61451, I/A 185 ( 8.08.12).

10 de Julio de 2012
Ceses/Dimisiones. Secretario: RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS JOSE. Consejero: RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS JOSE. Datosregistrales. T 28858 , F 162, S 8, H M 61451, I/A 183 (27.06.12).

05 de Julio de 2012
Modificaciones estatutarias. 4. Administraci贸n y Representacion.- (Reglamento del Consejode Administracion). Datos registrales.T 28858 , F 162, S 8, H M 61451, I/A 182 (25.06.12).

03 de Julio de 2012
Otros conceptos: MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO AL OBJETO DE ADAPTARLO AL REAL DECRETOLEGISLATIVO 1/2010, DE 2 DE JULIO. Datos registrales. T 28858 , F 160, S 8, H M 61451, I/A 181 (20.06.12).

21 de Mayo de 2012
Nombramientos. Consejero: PEREZ PRIM ANDRES-MARIA. Datos registrales. T 28858 , F 160, S 8, H M 61451, I/A 180 (8.05.12).

18 de Mayo de 2012
Modificaciones estatutarias. 2. Objeto.-. 13. Funcionamiento Junta Gral.-. Cambio de objeto social. LA FABRICACION,COMERCIALIZACION, VENTA, DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO, IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODA CLASE DEMATERIAL ORTOPEDICO, MEDICO, QUIRURGICO, FARMACEUTICO. Datos registrales. T 28858 , F 157, S 8, H M 61451, I/A 178( 7.05.12).

Otros conceptos: APROBADA LA REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 28858 , F 158, S 8, H M61451, I/A 179 ( 7.05.12).

16 de Abril de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ FLORES FUNES FRANCISCO. Datos registrales. T 28858 , F 157, S 8, H M 61451,I/A 177 ( 2.04.12).

28 de Marzo de 2012
Nombramientos. Apoderado: JUAREZ VILLAMAR MARIA INMACULADA. Datos registrales. T 28858 , F 157, S 8, H M 61451, I/A

19 de Agosto de 2011
Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SL. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 28858 , F 156, S 8, H M61451, I/A 175 ( 5.08.11).

11 de Agosto de 2011
Otros conceptos: HAN QUEDADO MODIFICADOS LOS ARTICULOS 10, 11, 12, 20, 21, 21 BIS, 24, 26 Y 27 DE LOS ESTATUTOSSOCIALES.- Datos registrales. T 18639 , F 47, S 8, H M 61451, I/A 173 ( 1.08.11).

Otros conceptos: HAN QUEDADO MODIFICADOS LOS ARTICULOS 1, 4, 5 Y 11 DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA Y HAQUEDADO REFUNDIDO EL TEXTO INTEGRO DEL MISMO.- Datos registrales. T 28858 , F 153, S 8, H M 61451, I/A 174 ( 1.08.11).

15 de Marzo de 2011
Nombramientos. Apoderado: PRIM MARTINEZ IGNACIO. Datos registrales. T 18639 , F 47, S 8, H M 61451, I/A 172 ( 3.03.11).

29 de Noviembre de 2010
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ FLORES FUNES FRANCISCO. Datos registrales. T 18639 , F 46, S 8, H M 61451, I/A171 (17.11.10).

04 de Noviembre de 2010
Revocaciones. Apoderado: OSORIO PORRAS JOSE LUIS. Datos registrales. T 18639 , F 46, S 8, H M 61451, I/A 170 (21.10.10).

13 de Octubre de 2010
Reelecciones. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 18639 , F 46, S 8, H M 61451,I/A 169 (30.09.10).

13 de Agosto de 2010
Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 24潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 18639 , F46, S 8, H M 61451, I/A 168 ( 3.08.10).

05 de Agosto de 2010
Reelecciones. Consejero: PEREZ DE MENDEZONA JUAN JOSE;BARTAL INVERSIONES SL. Vicepresid.: BARTAL INVERSIONESSL. Datos registrales. T 18639 , F 45, S 8, H M 61451, I/A 167 (26.07.10).

20 de Mayo de 2010
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: PRIM GONZALEZ VICTORIANO. Datos registrales. T 18639 , F 45, S 8, H M 61451, I/A 166 (7.05.10).

30 de Diciembre de 2009
Revocaciones. Apoderado: GRAND MONTER LUIS. Datos registrales. T 18639 , F 45, S 8, H M 61451, I/A 165 (16.12.09).

12 de Noviembre de 2009
Nombramientos. Apo.Sol.: DEZA ANTA ESPERANZA;VICENTE HERNANDO ALEJANDRO. Datos registrales. T 18639 , F 45, S 8,H M 61451, I/A 164 ( 2.11.09).

31 de Agosto de 2009
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG. Datos registrales. T 18639 , F 44, S 8, H M 61451,I/A 163 (19.08.09).

24 de Julio de 2009
Reelecciones. Secretario: RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS JOSE. Consejero: RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS JOSE. Datosregistrales. T 18639 , F 44, S 8, H M 61451, I/A 162 (15.07.09).

12 de Junio de 2009
Otros conceptos: REVOCADOS LOS PODERES CONFERIDOS EN VIRTUD DE ESCRITURA AUTORIZADA EL DIA 24 DE ENERODE 1967, POR EL NOTARIO DE MADRID, DON JOSE LUIS ALVAREZ ALVAREZ, BAJO EL NUMERO DE PROTOCOLO270 QUECAUSO LA INSCRIPCION 4& DE LA HOJA SOCIAL.REVOCADOS LOS PODERES CONFERIDOS EN VIRTUD DE ESCRITURAAUTORIZADA POR EL NOTARIO DE MADRID, DON JOSE LUIS ALVAREZ ALVAREZ, EL DIA 29 DE ENERO DE 1974, BAJO ELNUMERO DE PROTOCOLO458, QUE CAUSO LA INSCRIPCION 14& DE LA HOJA SOCIAL.REVOCADO EL PODER CONFERIDOEN VIRTUD DE ESCRITURA AUTORIZADA POR EL NOTARIO DE MADRID, DON JOSE ANTONIO MOLLEDA FERNANDEZ-LLAMAZARES, EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 1978, BAJO EL NUMERO 1274 DE SU PROTOCOLO, QUE CAUSO LA INSCRIPCION28& DE LA HOJA SOCIAL. Datos registrales. T 18639 , F 43, S 8, H M 61451, I/A 161 ( 1.06.09).

04 de Febrero de 2009
Nombramientos. Apoderado: MEIJIDE GARCIA JOSE LUIS. Datos registrales. T 18639 , F 43, S 8, H M 61451, I/A 160 (23.01.09).

23 de Enero de 2009
Otros conceptos: ADMISION A NEGOCIACION DE 1.577.011 ACCIONES EN LA BOLSA DEVALORES DE MADRID. Datosregistrales. T 18639 , F 43, S 8, H M 61451, I/A 158 (13.01.09).

Otros conceptos: ADMISION A NEGOCIACION DE 1.577.011 ACCIONES EN LA BOLSA DEVALORES DE VALENCIA. Datosregistrales. T 18639 , F 43, S 8, H M 61451, I/A 159 (13.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n