Buscador CIF Logo

Actos BORME Probelte Biotecnologia Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Probelte Biotecnologia Sl

Actos BORME Probelte Biotecnologia Sl - B73583361

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Murcia para Probelte Biotecnologia Sl con CIF B73583361

馃敊 Perfil de Probelte Biotecnologia Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Murcia

Actos BORME de Probelte Biotecnologia Sl

30 de Noviembre de 2021
Reelecciones. Adm. Unico: ESTER BELMONTE GOMEZ. Datos registrales. T 2921 , F 80, S 8, H MU 69031, I/A 20 (23.11.21).

12 de Julio de 2016
Nombramientos. Apo.Sol.: MARIA RESURECCION CARAVACA EGEA;ANTONIO CEREZO ABELLAN. Datos registrales. T 2921 ,F 80, S 8, H MU 69031, I/A 18 ( 5.07.16).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARIANO ALMANSA ORTIN;ANA JOSE BELMONTE GOMEZ. Apo.Manc.: JUAN LOPEZ ORENES.Apo.Man.Soli: MARIANO ALMANSA ORTIN;JUAN LOPEZ ORENES;LUIS ORTS LLOPIS. Apo.Manc.: MARIANO ALMANSAORTIN;JUAN LOPEZ ORENES. Datos registrales. T 2921 , F 80, S 8, H MU 69031, I/A 19 ( 5.07.16).

24 de Diciembre de 2015
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: PROBELTE PHARMA SL. Datos registrales. T 2921 , F 79, S 8, H MU 69031, I/A17 (17.12.15).

25 de Noviembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: JOSE MANUEL CASANOVA ABADIA;ANA JOSE BELMONTE GOMEZ;ESTHER BELMONTEGOMEZ. Presidente: JOSE MANUEL CASANOVA ABADIA. Co.De.Ma.So: JOSE MANUEL CASANOVA ABADIA. SecreNoConsj:JUAN LOPEZ ORENES. VsecrNoConsj: MAXIMILIANO CASTILLO GONZALEZ. Nombramientos. Adm. Unico: ESTER BELMONTEGOMEZ. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. SE MODIFICAEL ARTICULO 9 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 2921 , F 79, S 8, H MU 69031, I/A 16 (18.11.15).

20 de Agosto de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: LUIS ORTS LLOPIS. Co.De.Ma.So: LUIS ORTS LLOPIS. Datos registrales. T 2921 , F 79, S 8, HMU 69031, I/A 15 (13.08.15).

30 de Enero de 2015
Ampliaci贸n de capital. Capital: 556.240,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.786.240,00 Euros. Datos registrales. T 2921 , F 78, S 8, HMU 69031, I/A 14 (23.01.15).

12 de Febrero de 2014
Otros conceptos: SE MODIFICA EL APARTADO D) DEL ARTICULO 6 Y EL ARTICULO 14 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.Datos registrales. T 2921 , F 78, S 8, H MU 69031, I/A 13 ( 4.02.14).

14 de Marzo de 2013
Cambio de domicilio social. C/ ANTONIO BELMONTE ABELLAN 3-7 (MURCIA). Datos registrales. T 2921 , F 78, S 8, H MU69031, I/A 12 ( 7.03.13).

04 de Febrero de 2013
Nombramientos. Co.De.Ma.So: LUIS ORTS LLOPIS. Datos registrales. T 2921 , F 78, S 8, H MU 69031, I/A 11 (28.01.13).

31 de Diciembre de 2012
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARIANO ALMANSA ORTIN;JUAN LOPEZ ORENES. Datos registrales. T 2921 , F 76, S 8, H MU69031, I/A 9 (20.12.12).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: LUIS ORTS LLOPIS. Apo.Manc.: MARIANO ALMANSA ORTIN;JUAN LOPEZ ORENES. Datosregistrales. T 2921 , F 77, S 8, H MU 69031, I/A 10 (20.12.12).

27 de Diciembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: ANA GOMEZ RODRIGUEZ. Presidente: ANA GOMEZ RODRIGUEZ. Secretario: PEDRO MARTINEZORTIZ. Cons.Del.Man: ANA GOMEZ RODRIGUEZ. Nombramientos. Presidente: JOSE MANUEL CASANOVA ABADIA.SecreNoConsj: JUAN LOPEZ ORENES. Otros conceptos: Como consecuencia de la renuncia del consejero delegado cambian laactuacion de los consejeros delegados. Datos registrales. T 2623 , F 170, S 8, H MU 69031, I/A 7 (19.12.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: PEDRO MARTINEZ ORTIZ;ANA JOSE BELMONTE GOMEZ;ESTHER BELMONTE GOMEZ.Cons.Del.Man: ANA JOSE BELMONTE GOMEZ;ESTHER BELMONTE GOMEZ;PEDRO MARTINEZ ORTIZ. Consejero: JOSEMANUEL CASANOVA ABADIA. Cons.Del.Man: JOSE MANUEL CASANOVA ABADIA. Presidente: JOSE MANUEL CASANOVAABADIA. SecreNoConsj: JUAN LOPEZ ORENES. Revocaciones. Apo.Man.Soli: PEDRO MARTINEZ ORTIZ. Nombramientos.Consejero: JOSE MANUEL CASANOVA ABADIA;ANA JOSE BELMONTE GOMEZ;ESTHER BELMONTE GOMEZ;LUIS ORTSLLOPIS. Presidente: JOSE MANUEL CASANOVA ABADIA. Co.De.Ma.So: JOSE MANUEL CASANOVA ABADIA. Cons.Del.Man: ANAJOSE BELMONTE GOMEZ;ESTHER BELMONTE GOMEZ. SecreNoConsj: JUAN LOPEZ ORENES. Datos registrales. T 2921 , F76, S 8, H MU 69031, I/A 8 (19.12.12).

27 de Noviembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: CARMEN BELMONTE GOMEZ. Nombramientos. Consejero: JOSE MANUEL CASANOVAABADIA. Cons.Del.Man: JOSE MANUEL CASANOVA ABADIA. Datos registrales. T 2623 , F 170, S 8, H MU 69031, I/A 6 (16.11.12).

11 de Agosto de 2011
Nombramientos. Apo.Manc.: JUAN LOPEZ ORENES. Datos registrales. T 2623 , F 169, S 8, H MU 69031, I/A 5 ( 3.08.11).

29 de Julio de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: ANTONIO BELMONTE ABELLAN. Presidente: ANTONIO BELMONTE ABELLAN. Consejero: PEDROMARTINEZ ORTIZ. Secretario: PEDRO MARTINEZ ORTIZ. Consejero: CARMEN BELMONTE GOMEZ;ANA JOSE BELMONTEGOMEZ;ESTHER BELMONTE GOMEZ;MARIANO ALMANSA ORTIN;JOSE-ANTONIO BELMONTE SANCHEZ. Nombramientos.Consejero: ANA GOMEZ RODRIGUEZ. Presidente: ANA GOMEZ RODRIGUEZ. Consejero: PEDRO MARTINEZ ORTIZ. Secretario:

31 de Mayo de 2010
Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.222.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.230.000,00 Euros. Datos registrales. T 2623 , F 168, S8, H MU 69031, I/A 3 (20.05.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n