Actos BORME de Proceba Exterior Sociedad Anonima
12 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: COTONER MACAYA BELTRAN SANTIAGO;TOLEDANO NU脩EZ LUIS MARTIN. Datos registrales. T24777 , F 111, S 8, H M 445950, I/A 10 ( 3.11.21).
Revocaciones. Apoderado: PEDRO HERNANDEZ BERNAL;MARTINEZ LOPEZ FERNANDO;MARTINEZ LOPEZ FERNANDO.Datos registrales. T 24777 , F 111, S 8, H M 445950, I/A 9 ( 3.11.21).
10 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apoderado: RIVERA SERRANO VALERIANO. Datos registrales. T 24777 , F 111, S 8, H M 445950, I/A 8 (2.11.21).
30 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ LOPEZ FERNANDO. Datos registrales. T 24777 , F 111, S 8, H M 445950, I/A 7(23.11.18).
17 de Octubre de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: COTONER MARTOS NICOLAS;COTONER MARTOS I脩IGO;COTONER MARTOS JOSE LUIS.Nombramientos. Adm. Solid.: COTONER MARTOS NICOLAS;COTONER MARTOS I脩IGO;COTONER MARTOS JOSE LUIS. Datosregistrales. T 24777 , F 110, S 8, H M 445950, I/A 6 ( 9.10.18).
03 de Diciembre de 2013Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ LOPEZ FERNANDO. Datos registrales. T 24777 , F 110, S 8, H M 445950, I/A 5(25.11.13).
30 de Octubre de 2012Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: COTONER MARTOS NICOLAS;I脩IGO COTONER MARTOS;JOSE LUIS COTONER MARTOS.Nombramientos. Adm. Solid.: COTONER MARTOS NICOLAS;COTONER MARTOS I脩IGO;COTONER MARTOS JOSE LUIS.Modificaciones estatutarias. 15. Duraci贸n y retribuci贸n del cargo de Administrador. Datos registrales. T 24777 , F 109, S 8, H M445950, I/A 4 (18.10.12).
21 de Abril de 2010Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 280.005,90 Euros. Desembolsado: 280.005,90 Euros. Resultante Suscrito: 472.325,90 Euros.Resultante Desembolsado: 472.325,90 Euros. Datos registrales. T 24777 , F 107, S 8, H M 445950, I/A 3 (12.04.10).