Actos BORME de Procgeri Gestion Xxi Sl
10 de Octubre de 2023Modificaci贸n de poderes. Apo.Sol.: SCHULLER DE SANTOS DAVID CARLOS. Datos registrales. T 4283, L 4283, F 212, S 8, HPO 59154, I/A 55 ( 2.10.23).
29 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ VAZQUEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 4283, L 4283, F 99, S 8, H PO 59154, I/A54 (21.09.23).
17 de Agosto de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: SOLLA TORRES JOSE MANUEL. Datos registrales. T 4283, L 4283, F 99, S 8, H PO 59154, I/A 53 (8.08.23).
04 de Agosto de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ LORENZO DIEGO;ROJAS RODRIGUEZ VICTORIA;SARMINI SAINZALBERTO;FERNANDEZ MIGUELEZ PEDRO;VILLAVERDE MARTINEZ ANA ISABEL;VICENTE ARCOS MARIA CARMEN;SOLLATORRES JOSE MANUEL;BRAVO ARAGON PEDRO;RECUENCO COTILLAS PILAR;ALZAMORA CA脩ERO ELENA;SARRATOMARTINEZ FRANCISCO JAVIER;REYES PONCE MONICA;RODRIGUEZ IGLESIAS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4283, L 4283,F 98, S 8, H PO 59154, I/A 52 (26.07.23).
28 de Julio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN GARCIA ELENA. Datos registrales. T 4283, L 4283, F 98, S 8, H PO 59154, I/A 51 (20.07.23).
27 de Julio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: SCHULLER DE SANTOS DAVID CARLOS. Datos registrales. T 4283, L 4283, F 97, S 8, H PO 59154,I/A 50 (18.07.23).
24 de Julio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: MONTERO QUINTELA SANDRA;TAUSTE BAUTISTA HUGO;LAGUNA VALENZUELA MARIA CRISTINA.Datos registrales. T 4283, L 4283, F 97, S 8, H PO 59154, I/A 49 (13.07.23).
16 de Junio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: RUBIO PERIA脩EZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 4283, L 4283, F 95, S 8, H PO 59154, I/A 45 (8.06.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: TARDIN SANCHEZ CAROLINA. Datos registrales. T 4283, L 4283, F 96, S 8, H PO 59154, I/A 46 (8.06.23).
21 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE;FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4283, L 4283, F95, S 8, H PO 59154, I/A 44 (14.11.22).
07 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apoderado: CUETO FAUS JOSE LUIS. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS;CUETO FAUS JOSE LUIS. Datosregistrales. T 4283, L 4283, F 95, S 8, H PO 59154, I/A 43 (27.10.22).
03 de Agosto de 2022Revocaciones. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI;SOLER VICENS ANTONI. Apo.Sol.: SOLER VICENS ANTONI;SOLER VICENSANTONI. Datos registrales. T 4283, L 4283, F 95, S 8, H PO 59154, I/A 42 (26.07.22).
20 de Enero de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFINA. Nombramientos. Adm. Unico: GERIATRICOS DELPRINCIPADO SA. Datos registrales. T 4283, L 4283, F 94, S 8, H PO 59154, I/A 41 (11.01.22).
04 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 4283, L 4283, F 94, S 8, H PO 59154, I/A 40(26.10.21).
03 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 4283, L 4283, F 92, S 8, H PO 59154, I/A 39(22.10.21).
26 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CALVO DIEGUEZ MONICA. Datos registrales. T 4283, L 4283, F 92, S 8, H PO 59154, I/A 38(15.10.21).
21 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4283, L 4283, F 91, S 8, H PO 59154, I/A 37 (13.10.21).
19 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4283, L 4283, F 91, S 8, H PO 59154, I/A 36 ( 7.10.21).
25 de Mayo de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ ALONSO LUIS MANUEL. Datos registrales. T 4283, L 4283, F 91, S 8, H PO 59154, I/A 35(18.05.21).
06 de Mayo de 2021Revocaciones. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 4283, L 4283, F 91, S 8, H PO59154, I/A 34 (26.04.21).
07 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4283, L 4283, F 90, S 8, H PO 59154, I/A 33(31.07.20).
26 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 4283, L 4283, F 90, S 8, H PO59154, I/A 32 (22.06.20).
24 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: MARIN SORRIBES ANA. Datos registrales. T 4283, L 4283, F 90, S 8, H PO 59154, I/A 31 (18.06.20).
13 de Abril de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: ORTS SAN JOSE ALFREDO. Datos registrales. T 4283, L 4283, F 90, S 8, H PO 59154, I/A 30 ( 3.04.20).
23 de Octubre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: PRIEGO DEL RIO SANDRA. Datos registrales. T 4283, L 4283, F 90, S 8, H PO 59154, I/A 29 (15.10.19).
27 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: TABOADA FERNANDEZ MARIA. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 129, S 8, H PO 59154, I/A 28(16.05.19).
13 de Mayo de 2019Revocaciones. Apoderado: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 129, S 8, H PO 59154, I/A 27 ( 7.05.19).
16 de Noviembre de 2018Revocaciones. Apoderado: PENAS GARCIA MARIA JESUS. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 128, S 8, H PO 59154, I/A 25 (9.11.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 128, S 8, H PO 59154, I/A 26 (12.11.18).
24 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: LOPESINO SOUSA AGUSTIN MODESTO. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 127, S 8, H PO59154, I/A 24 (17.07.18).
02 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 127, S 8, H PO 59154, I/A 23(26.06.18).
12 de Junio de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ MARTINEZ ISABEL. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 127, S 8, H PO 59154, I/A 22 (6.06.18).
16 de Marzo de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: CUNCHILLOS HIDALGO MARIA CARMEN. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 126, S 8, H PO 59154,I/A 21 ( 9.03.18).
12 de Marzo de 2018Revocaciones. Apoderado: GALLOFRE PASCUAL ROMAN. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 126, S 8, H PO 59154, I/A 20 (2.03.18).
19 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO VAN DER SCHOOT MANUEL. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 126, S 8, H PO 59154,I/A 17 (12.02.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: ORTS SAN JOSE ALFREDO. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 126, S 8, H PO 59154, I/A 18(12.02.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: GUTIERREZ HERREROS ARANTZAZU. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 126, S 8, H PO 59154, I/A19 (12.02.18).
16 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 125, S 8, H PO 59154, I/A 16 ( 9.02.18).
04 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 124, S 8, H PO 59154, I/A 15(25.08.17).
28 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 123, S 8, H PO 59154, I/A 12 (20.07.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: DURAN MARI脩O MARIA;DEL CAMPO REDONDO LUCIA;MELON CASTRO MARIA JOSE. Datosregistrales. T 4199, L 4199, F 124, S 8, H PO 59154, I/A 13 (24.07.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: PALENZUELA FERNANDEZ JAVIER;PITEL MENDEZ MARIA EUGENIA;RODRIGUEZ MARTINEZISABEL;PRIEGO DEL RIO SANDRA. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 124, S 8, H PO 59154, I/A 14 (24.07.17).
26 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ CALAVIA JAVIER. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 123, S 8, H PO 59154, I/A 11(19.07.17).
25 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 120, S 8, H PO 59154, I/A 10(18.07.17).
26 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 120, S 8, H PO 59154, I/A 8(16.06.17).
Nombramientos. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 120, S 8, H PO 59154, I/A 9(19.06.17).
23 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: GALLOFRE PASCUAL ROMAN. Datos registrales. T 4073, L 4073, F 196, S 8, H PO 59154, I/A 7(15.06.17).
22 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: LOPESINO SOUSA AGUSTIN. Datos registrales. T 4073, L 4073, F 196, S 8, H PO 59154, I/A 6(14.06.17).
21 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: ROSELLO RIERA JOSE-LUIS. Datos registrales. T 4073, L 4073, F 193, S 8, H PO 59154, I/A 5(14.06.17).
20 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: HUGUET LLULL ANDREU. Datos registrales. T 4073, L 4073, F 189, S 8, H PO 59154, I/A 4(12.06.17).
18 de Marzo de 2016Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12. Datos registrales. T 4073, L 4073, F 189, S 8, H PO 59154, I/A 3( 9.03.16).
02 de Noviembre de 2015Cambio de domicilio social. AVDA GARCIA BARBON 60 (VIGO). Datos registrales. T 4073, L 4073, F 170, S 8, H PO 59154, I/A 1(26.10.15).
Otros conceptos: MODIFICADO el art铆culo 4 de los estatutos sociales correspondiente al DOMICILIO SOCIAL. Datos registrales. T4073, L 4073, F 189, S 8, H PO 59154, I/A 2 (26.10.15).
30 de Septiembre de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFINA;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS III SL.Nombramientos. Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFINA. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Administradores mancomunados a Administrador 煤nico. Ratificaci贸n de las actuaciones efectuadas por los administradores salienteshasta el 4 de junio de 2015. Datos registrales. T 1485 , F 72, S 8, H NA 29512, I/A 7 (21.09.15).
11 de Junio de 2014Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GERIATRICOS DEL PRINCIPADO SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: COCINAPALACIO JESUS;CAMPOS MENENDEZ JOSE LUIS;ALONSO VALLAURE JESUS;GONZALEZ GONZALEZ PAULO;MARTINEZPEREZ CONSTANTINO;HERRERO BERENGUER JUAN LUIS;MARTINEZ MARTINEZ DAVID. Presidente: COCINA PALACIOJESUS. Secretario: GONZALEZ GONZALEZ PAULO. Con.Delegado: ALONSO VALLAURE JESUS;CAMPOS MENENDEZ JOSELUIS. Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ GONZALEZ PAULO;MARIN ABIZANDA JOSE FERNANDO. Nombramientos. Adm.Mancom.: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFINA;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS III SL. Apoderado: FERNANDEZ MIGUELEZJOSEFINA;PENAS GARCIA MARIA JESUS. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administradores mancomunados. Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/9. Otros conceptos: DESIGNADA persona f铆sicarepresentante del administrador "MAGNUM BUSINESS DIRECTORS III, S. L.", Don Alberto Bermejo Madera. Datos registrales. T1485 , F 71, S 8, H NA 29512, I/A 6 (29.05.14).
24 de Mayo de 2012Nombramientos. Apoderado: MARIN ABIZANDA JOSE FERNANDO. Datos registrales. T 1485 , F 71, S 8, H NA 29512, I/A 5(15.05.12).
14 de Junio de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 196.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 200.000,00 Euros. Datos registrales. T 1485 , F 71, S 8, HNA 29512, I/A 4 ( 1.06.11).
22 de Diciembre de 2009Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ GONZALEZ PAULO. Datos registrales. T 1485 , F 67, S 8, H NA029512, I/A00003 (9.12.09).
23 de Noviembre de 2009Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 11.09.09. Objeto social: La sociedad tiene por objeto: a.- La explotaci贸n de residencias de laTercera Edad, Cl铆nicas geri谩tricas y establecimientos similares. b.- La explotaci贸n de todo tipo de negocios o establecimientos del ramode la hosteler铆a,cafeter铆as, bares, restaurantes, hoteles y otros establecimientos similares. c.- La promoci贸n de edificaciones,directamente o como mediadora en comun. Domicilio: CALLE SANTA GEMA, n潞 60,SAN ADRIAN (SAN ADRIAN). Capital: 4.000,00Euros. Nombramientos. Consejero: COCINA PALACIO JESUS;CAMPOS MENENDEZ JOSE LUIS;ALONSO VALLAUREJESUS;GONZALEZ GONZALEZ PAULO;MARTINEZ PEREZ CONSTANTINO;HERRERO BERENGUER JUAN LUIS;MARTINEZMARTINEZ DAVID. Datos registrales. T 1485 , F 67, S 8, H NA029512, I/A00001 (11.11.09).
Nombramientos. Presidente: COCINA PALACIO JESUS. Secretario: GONZALEZ GONZALEZ PAULO. Cons.Delegad: ALONSOVALLAURE JESUS;CAMPOS MENENDEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 1485 , F 67, S 8, H NA029512, I/A00002 (11.11.09).