Buscador CIF Logo

Actos BORME Procubitos Europe Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Procubitos Europe Sl

Actos BORME Procubitos Europe Sl - B88073739

Tenemos registrados 14 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Procubitos Europe Sl con CIF B88073739

馃敊 Perfil de Procubitos Europe Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Procubitos Europe Sl

05 de Mayo de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: GUERRERO IGEA FELIX MANUEL. Presidente: GUERRERO IGEA FELIX MANUEL.Nombramientos. Consejero: CENTELLES SATRUSTEGUI ENRIQUE. Presidente: CENTELLES SATRUSTEGUI ENRIQUE. Cambiode domicilio social. C/ DE LOS MINEROS 19 (PINTO). Datos registrales. T 37498 , F 199, S 8, H M 668431, I/A 20 (26.04.23).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: PLAZAS RUIZ FERNANDO;DELGADO TRAPIELLA FRANCISCO JOSE. Apo.Sol.: GONZALEZALONSO LUCI;GRANDA JUAN MONICA. Apo.Manc.: GUERRERO IGEA FELIX MANUEL;LOPEZ ARMENTA RAFAEL;VAZQUEZGAVIRA MANUEL LUIS;VAZQUEZ GAVIRA MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Apoderado: CENTELLES SATRUSTEGUIENRIQUE;VAZQUEZ GAVIRA MANUEL LUIS;VAZQUEZ GAVIRA MIGUEL ANGEL;LOPEZ ARMENTA RAFAEL;PLAZAS RUIZFERNANDO;DELGADO TRAPIELLA FRANCISCO JOSE;GONZALEZ ALONSO LUCI;GRANDA JUAN MONICA. Datos registrales. T37498 , F 199, S 8, H M 668431, I/A 21 (26.04.23).

05 de Enero de 2023
Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 37498 , F198, S 8, H M 668431, I/A 19 (29.12.22).

22 de Abril de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: ROBLEDO POZAS MANUEL. Nombramientos. Consejero: BONO GUERRERO JOSEP. Datosregistrales. T 37498 , F 198, S 8, H M 668431, I/A 17 (13.04.22).

24 de Marzo de 2022
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PLAZAS RUIZ FERNANDO;DELGADO TRAPIELLA FRANCISCO JOSE. Apo.Sol.: GONZALEZ

17 de Febrero de 2022
Revocaciones. Apoderado: VAZQUEZ GAVIRA MIGUEL ANGEL;GUERRERO IGEA FELIX MANUEL;LOPEZ ARMENTARAFAEL;DELGADO TRAPIELLA FRANCISCO JOSE;VAZQUEZ GAVIRA MIGUEL ANGEL;GUERRERO IGEA FELIXMANUEL;LOPEZ ARMENTA RAFAEL. Datos registrales. T 37498 , F 195, S 8, H M 668431, I/A 15 (10.02.22).

18 de Noviembre de 2021
Otros conceptos: En el expediente sobre la concesi贸n de Incentivos Regionales n煤mero AV/205/P07, Se concede al titular unapr贸rroga extraordinaria en el final del plazo de vigencia de los beneficios hasta el 15 de Abril de 2019. Datos registrales. T 37498 , F194, S 8, H M 668431, I/A 13.M (11.11.21).

04 de Mayo de 2021
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Reelecciones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 37498 , F 195, S 8, H M668431, I/A 14 (26.04.21).

17 de Marzo de 2021
Cambio de objeto social. Fabricaci贸n, distribuci贸n y comercializaci贸n de hielo y cualesquiera envases para el ejercicio del mismo. Asimismo tiene por objeto la fabricaci贸n, manipulaci贸n, distribuci贸n y comercializaci贸n de toda clase de productos alimenticios. Fusi贸npor absorci贸n. Sociedades absorbidas: PROCUBITOS SL. CUBERS PREMIUM SL. INGENIERIA Y COMERCIALIZACION DELHIELO SL. Datos registrales. T 37498 , F 191, S 8, H M 668431, I/A 13 (10.03.21).

22 de Junio de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: ORZOLA INVERSIONES SL. Representan: ROBLEDO POZAS MANUEL. Nombramientos.Consejero: ROBLEDO POZAS MANUEL. Datos registrales. T 37498 , F 191, S 8, H M 668431, I/A 12 (15.06.20).

04 de Diciembre de 2019
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 37498 , F 191, S 8, H M 668431, I/A 11(27.11.19).

30 de Septiembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: ESCALES ESTRUCH JOSE RAMON. Nombramientos. Apoderado: DELGADO TRAPIELLAFRANCISCO JOSE;VAZQUEZ GAVIRA MIGUEL ANGEL;GUERRERO IGEA FELIX MANUEL;LOPEZ ARMENTA RAFAEL. Datosregistrales. T 37498 , F 82, S 8, H M 668431, I/A 10 (23.09.19).

17 de Julio de 2019
Ampliaci贸n de capital. Capital: 400.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.183.600,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culode los estatutos: 5. Capital social.-. Datos registrales. T 37498 , F 81, S 8, H M 668431, I/A 9 (10.07.19).

09 de Octubre de 2018
Revocaciones. Apoderado: VAZQUEZ GAVIRA MIGUEL ANGEL;GUERRERO IGEA FELIX MANUEL;LOPEZ ARMENTA RAFAEL.Nombramientos. Apoderado: VAZQUEZ GAVIRA MIGUEL ANGEL;GUERRERO IGEA FELIX MANUEL;LOPEZ ARMENTARAFAEL;ESCALES ESTRUCH JOSE RAMON. Datos registrales. T 37498 , F 79, S 8, H M 668431, I/A 8 ( 1.10.18).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n