Actos BORME de Prodinco Valles Sl
28 de Marzo de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 89.490,26 Euros. Resultante Suscrito: 3.100.952,73 Euros. Datos registrales. T 42176 , F40, S 8, H B 22944, I/A 33 (21.03.22).
21 de Enero de 2022Nombramientos. APODERAD.SOL: MOLINS DURAN JAUME. Datos registrales. T 40230 , F 20, S 8, H B 22944, I/A 32 (14.01.22).
24 de Noviembre de 2021Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 388.962,01 Euros. Resultante Suscrito: 3.190.442,99 Euros. Datos registrales. T 40230 ,F 19, S 8, H B 22944, I/A 31 (16.11.21).
21 de Septiembre de 2021Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: ROIG GRAELLS LLUIS;UBACH COMAS JORDI. Nombramientos. ADM.UNICO: UBACH COMASJORDI. Datos registrales. T 40230 , F 19, S 8, H B 22944, I/A 30 (13.09.21).
16 de Septiembre de 2021Fe de erratas: En el BORME no.25/2021 y con referencia 58596 SE RECTIFICA EL SEGUNDO APELLIDO DEL ADMINISTRADORSOLIDARIO NOMBRADO SE脩OR JORDI UBACH, SIENDO SU NOMBRE COMPLETO CORRECTO "JORDI UBACH COMAS".Datos registrales. T 40230 , F 18, S 8, H B 22944, I/A 29 (28.01.21).
08 de Febrero de 2021Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: ROIG GRAELLS LLUIS;UBACH TOMAS JORDI. Datos registrales. T 40230 , F 18, S 8, H B22944, I/A 29 (28.01.21).
30 de Octubre de 2015Revocaciones. SECR.NO CONS: ROCA VIVAS DANIEL. APODERADO: UBACH COMAS JORDI;ROIG GRAELLS LLUIS.CONSEJERO: ROIG GRAELLS LLUIS. PRESIDENTE: ROIG GRAELLS LLUIS. CONSEJERO: UBACH COMAS JORDI;PINEDASANTACANA BALTASAR;MOLINS DURAN JAUME;PUIGARNAU UBACH JAUME. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: ROIGGRAELLS LLUIS;UBACH COMAS JORDI. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 9 DE LOS ESTATUTOSSOCIALES. SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 40230 , F 18, S 8, H B22944, I/A 28 (22.10.15).
20 de Marzo de 2014Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 500.040,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.579.405,00 Euros. Datos registrales. T 40230 ,F 17, S 8, H B 22944, I/A 27 (12.03.14).
27 de Septiembre de 2013Revocaciones. CONSEJERO: PINEDA GARCIA RICARD. Nombramientos. CONSEJERO: PUIGARNAU UBACH JAUME.Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.359.815,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.079.445,00 Euros. Otros conceptos:RECTIFICADA LA INS.18 EN CUANTO A LA REDACCION DEL ARTICULO RELATIVO AL CAPITAL SOCIAL. Datos registrales. T40230 , F 15, S 8, H B 22944, I/A 26 (18.09.13).
23 de Agosto de 2012Revocaciones. CONSEJERO: PINEDA SANTACANA BALTASAR;MOLINS DURAN JAUME;UBACH COMAS JORDI;ROIGGRAELLS LLUIS. PRESIDENTE: ROIG GRAELLS LLUIS. Nombramientos. CONSEJERO: ROIG GRAELLS LLUIS. PRESIDENTE:ROIG GRAELLS LLUIS. CONSEJERO: UBACH COMAS JORDI;PINEDA SANTACANA BALTASAR;MOLINS DURAN JAUME. Datosregistrales. T 40230 , F 15, S 8, H B 22944, I/A 25 (13.08.12).
12 de Mayo de 2009Nombramientos. CONSEJERO: PINEDA GARCIA RICARD. Datos registrales. T 40230 , F 15, S 8, H B 22944, I/A 24 (28.04.09).
16 de Abril de 2009Revocaciones. CONSEJERO: PINEDA GARCIA SANTIAGO. Nombramientos. CONSEJERO: PUIGARNAU UBACH JAUME.Datos registrales. T 40230 , F 13, S 8, H B 22944, I/A 21 (31.03.09).
Nombramientos. APODERADO: UBACH COMAS JORDI;ROIG GRAELLS LLUIS. Datos registrales. T 40230 , F 14, S 8, H B22944, I/A 22 (31.03.09).
Revocaciones. APODERADO: PINEDA SANTACANA BALTASSAR. Datos registrales. T 40230 , F 15, S 8, H B 22944, I/A 23(31.03.09).