Actos BORME de Prodol Meditec Sociedad Anonima
13 de Octubre de 2023Nombramientos. Apoderado: RUIZ RUIZ LUIS ANTONIO. Datos registrales. T 3766 , F 56, S 8, H BI 35986, I/A 24 ( 3.10.23).
19 de Octubre de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: DELCLAUX DE LA SOTA ALBERTO;BASAGOITI ZAVALA ALFONSO;GANDARIAS LOZANOYOLANDA;GARTEIZ GANDARIAS FERNANDO. Con.Delegado: GARTEIZ GANDARIAS FERNANDO. Consejero: ARTOLA UGARTEJOSE IGNACIO;SALAZAR SALEGUI PEDRO JOSE;ARTOLA AGUINAGA JAIME. Presidente: DELCLAUX DE LA SOTA ALBERTO.SecreNoConsj: BEREINCUA GANDARIAS ALFONSO. Nombramientos. SecreNoConsj: BEREINCUA GANDARIAS ALFONSO.Consejero: DELCLAUX DE LA SOTA ALBERTO;GARTEIZ GANDARIAS FERNANDO. Con.Delegado: GARTEIZ GANDARIASFERNANDO. Consejero: GANDARIAS LOZANO YOLANDA;BASAGOITI ZAVALA ALFONSO;ARTOLA UGARTE JOSEIGNACIO;SALAZAR SALEGUI PEDRO;ARTOLA AGUINAGA JAIME. Presidente: DELCLAUX DE LA SOTA ALBERTO. Datosregistrales. T 3766 , F 54, S 8, H BI 35986, I/A 23 ( 6.10.22).
25 de Enero de 2021Cambio de domicilio social. MUELL TOMAS OLABARRI 5 3潞 D (GETXO). Datos registrales. T 3766 , F 54, S 8, H BI 35986, I/A 22(13.01.21).
09 de Mayo de 2019Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 29.640,00 Euros. Desembolsado: 29.640,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.185.440,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.185.440,00 Euros. Datos registrales. T 3272 , F 225, S 8, H BI 35986, I/A 21 (26.04.19).
17 de Octubre de 2016Reelecciones. SecreNoConsj: BEREINCUA GANDARIAS ALFONSO. Consejero: DELCLAUX DE LA SOTA ALBERTO;BASAGOITIZAVALA ALFONSO;GANDARIAS LOZANO YOLANDA;GARTEIZ GANDARIAS FERNANDO. Con.Delegado: GARTEIZ GANDARIASFERNANDO. Consejero: ARTOLA UGARTE JOSE IGNACIO;SALAZAR SALEGUI PEDRO JOSE;ARTOLA AGUINAGA JAIME.Presidente: DELCLAUX DE LA SOTA ALBERTO. Datos registrales. T 3272 , F 225, S 8, H BI 35986, I/A 20 ( 5.10.16).
19 de Noviembre de 2013Ceses/Dimisiones. Secretario: BASAGOITI ZAVALA ALFONSO. Nombramientos. SecreNoConsj: BEREINCUA GANDARIASALFONSO. Consejero: ARTOLA UGARTE JOSE IGNACIO;SALAZAR SALEGUI PEDRO JOSE;ARTOLA AGUINAGA JAIME.Modificaciones estatutarias. Art. 12.- La Administraci贸n y representaci贸n de la Sociedad correspondera al organo de administraci贸nconstituido por unconsejo de administraci贸n.....12 bis.- El cargo de Administrador no ser谩 retribuido por las funciones que desarrollecomo tal..... Datos registrales. T 3272 , F 224, S 8, H BI 35986, I/A 19 ( 7.11.13).
04 de Junio de 2013Modificaciones estatutarias. Modificados los art铆culos 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 y 16 de los estatutos sociales. . Datosregistrales. T 3272 , F 223, S 8, H BI 35986, I/A 18 (22.05.13).
31 de Marzo de 2011Revocaciones. Apo.Sol.: ACHA GANDARIAS PEDRO;GARTEIZ GANDARIAS FERNANDO. Datos registrales. T 3272 , F 223, S 8,H BI 35986, I/A 17 (16.03.11).
28 de Febrero de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: ACHA GANDARIAS PEDRO. Presidente: ACHA GANDARIAS PEDRO. Consejero: GANDARIASLOZANO YOLANDA;ARTOLA UGARTE FELIPE;DELCLAUX DE LA SOTA ALBERTO JOSE;GARTEIZ GANDARIAS FERNANDO.Con.Delegado: GARTEIZ GANDARIAS FERNANDO. Consejero: BASAGOITI ZABALA ALFONSO. Nombramientos. Consejero:DELCLAUX DE LA SOTA ALBERTO. Presidente: DELCLAUX DE LA SOTA ALBERTO. Consejero: BASAGOITI ZAVALA ALFONSO.Secretario: BASAGOITI ZAVALA ALFONSO. Consejero: GANDARIAS LOZANO YOLANDA;GARTEIZ GANDARIAS FERNANDO.Con.Delegado: GARTEIZ GANDARIAS FERNANDO. Modificaciones estatutarias. 7. Transmisi贸n de acciones.. 12. Consejo deAdministraci贸n .-. Datos registrales. T 3272 , F 221, S 8, H BI 35986, I/A 16 (17.02.11).
24 de Agosto de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 57.700,00 Euros. Desembolsado: 57.700,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.155.800,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.155.800,00 Euros. Datos registrales. T 3272 , F 221, S 8, H BI 35986, I/A 15 ( 3.08.09).
30 de Abril de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 52.300,00 Euros. Desembolsado: 52.300,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.098.100,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.098.100,00 Euros. Otros conceptos: Se modifican los art铆culos 5潞, 7潞, 12潞 y se crea el art铆culo 12潞 bis.Datos registrales. T 3272 , F 219, S 8, H BI 35986, I/A 14 (14.04.09).