Buscador CIF Logo

Actos BORME Productos Guadalhorce Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Productos Guadalhorce Sl

Actos BORME Productos Guadalhorce Sl - B29089281

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Cordoba para Productos Guadalhorce Sl con CIF B29089281

馃敊 Perfil de Productos Guadalhorce Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Cordoba

Actos BORME de Productos Guadalhorce Sl

12 de Septiembre de 2022
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 2660 , F 139, S 8, H CO 39749, I/A 7 ( 2.09.22).

01 de Diciembre de 2021
Reelecciones. Auditor: ACORDIA FGV AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 2660 , F 139, S 8, H CO 39749,I/A 6 (25.11.21).

28 de Diciembre de 2020
Reelecciones. Auditor: ACORDIA FGV AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 2660 , F 139, S 8, H CO 39749,I/A 5 (18.12.20).

17 de Enero de 2020
Reelecciones. Auditor: ACORDIA FGV AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 2660 , F 138, S 8, H CO 39749,I/A 4 (10.01.20).

22 de Enero de 2019
Reelecciones. Auditor: ACORDIA FGV AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 2660 , F 138, S 8, H CO 39749,I/A 3 (14.01.19).

12 de Diciembre de 2018
Cambio de domicilio social. AVDA AGRUPACION CORDOBA 17 (CORDOBA). Datos registrales. T 2660 , F 138, S 8, H CO39749, I/A 2 ( 3.12.18).

10 de Diciembre de 2015
Nombramientos. Auditor: ACORDIA FGV AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 4728, L 3636, F 47, S 8, H MA4513, I/A 40 ( 1.12.15).

27 de Noviembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: JIMENEZ ROMERO FRANCISCO. Nombramientos. Adm. Unico: JIMENEZ SAN MARTINFRANCISCO. Datos registrales. T 4728, L 3636, F 47, S 8, H MA 4513, I/A 39 (19.11.13).

16 de Enero de 2012
Reelecciones. Auditor: FGV AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 4728, L 3636, F 46, S 8, H MA 4513, I/A 38(29.12.11).

29 de Abril de 2011
Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ OCA脩A MANUEL JESUS. Datos registrales. T 4728, L 3636, F 46, S 8, H MA 4513, I/A 36(11.04.11).

18 de Enero de 2011
Reelecciones. Auditor: FGV AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 4728, L 3636, F 46, S 8, H MA 4513, I/A 35( 3.01.11).

23 de Junio de 2010
Nombramientos. Apo.Sol.: COSTA RIVERA PEDRO LUIS;OLEA CHAMIZO RAFAEL. Datos registrales. T 4728, L 3636, F 45, S 8,H MA 4513, I/A 34 ( 4.06.10).

15 de Abril de 2010
Nombramientos. Apo.Manc.: COSTA RIVERA PEDRO LUIS;OLEA CHAMIZO RAFAEL. Datos registrales. T 4728, L 3636, F 44, S8, H MA 4513, I/A 30 (16.03.10).

Nombramientos. Apo.Sol.: ORTEGA VERDUGO FRANCISCO JAVIER;ROMERO REYES JOSE MANUEL;PI脩EIRO GALLARDOGERMAN Datos registrales. T 4728, L 3636, F 45, S 8, H MA 4513, I/A 31 (16.03.10).

Nombramientos. Apo.Sol.: JIMENEZ SAN MARTIN FRANCISCO;JIMENEZ SANMARTIN CARMEN. Datos registrales. T 4728, L3636, F 45, S 8, H MA 4513, I/A 32 (16.03.10).

31 de Marzo de 2010
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BENJUMEA DU BOIS PATRICIA. Nombramientos. Adm. Unico: JIMENEZ ROMEROFRANCISCO. Datos registrales. T 4728, L 3636, F 44, S 8, H MA 4513, I/A 29 (16.03.10).

Revocaciones. Apo.Manc.: FIGUERAS BENJUMEA ISABEL PATRICIA;FIGUERAS BENJUMEA ALBERTO;FIGUERAS BENJUMEAALMUDENA MARIA. Apo.Sol.: MORALES SANCHEZ PEDRO;PI脩EIRO GALLARDO GERMAN. Datos registrales. T 4728, L 3636, F45, S 8, H MA 4513, I/A 33 (16.03.10).

23 de Marzo de 2010
Reelecciones. Auditor: FGV AUDITORES Y CONSULTORES SL. Datos registrales. T 4728, L 3636, F 44, S 8, H MA 4513, I/A 28 (8.03.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n