Buscador CIF Logo

Actos BORME Productos Horticolas Fito Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Productos Horticolas Fito Sl

Actos BORME Productos Horticolas Fito Sl - B60152089

Tenemos registrados 19 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Productos Horticolas Fito Sl con CIF B60152089

馃敊 Perfil de Productos Horticolas Fito Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Productos Horticolas Fito Sl

01 de Diciembre de 2023
Nombramientos. APODERAD.SOL: FITO BAUCELLS EDUARD;FITO BAUCELLS XAVIER;FITO BAUCELLS ELISABET;FITOCASTELLS EULALIA. Datos registrales. T 48038 , F 117, S 8, H B 70885, I/A 34 (23.11.23).

21 de Noviembre de 2023
Nombramientos. AUDT.CTS.CON: DELOITTE SL. Datos registrales. T 48038 , F 117, S 8, H B 70885, I/A 33 (13.11.23).

25 de Noviembre de 2021
Escisi贸n parcial. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: PERE QUART SL. Datos registrales. T 43513 , F 107, S 8, H B 70885, I/A32 (16.11.21).

10 de Junio de 2021
Revocaciones. CONSEJERO: FITO BAUCELLS ANTONI. PRESIDENTE: FITO CASTELLS EULALIA. SECRETARIO: FITOBAUCELLS ANTONI. Nombramientos. SECR.NO CONS: LOZANO MORENO MARC. PRESIDENTE: FITO BAUCELLS EDUARD.Datos registrales. T 43513 , F 107, S 8, H B 70885, I/A 31 ( 2.06.21).

01 de Febrero de 2021
Nombramientos. AUDT.CTS.CON: DELOITTE SL. Datos registrales. T 43513 , F 107, S 8, H B 70885, I/A 30 (25.01.21).

24 de Diciembre de 2019
Nombramientos. APODERAD.SOL: FITO BAUCELLS ELISABETH. Datos registrales. T 43513 , F 106, S 8, H B 70885, I/A 29(16.12.19).

11 de Abril de 2018
Nombramientos. AUDT.CTS.CON: DELOITTE SL. Datos registrales. T 43513 , F 106, S 8, H B 70885, I/A 28 ( 4.04.18).

01 de Marzo de 2017
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: GUASCH LOPEZ AUDITORS SLP. Datos registrales. T 43513 , F 105, S 8, H B 70885, I/A 26(21.02.17).

Nombramientos. AUDT.CTS.CON: GUASCH LOPEZ AUDITORS SLP. Datos registrales. T 43513 , F 105, S 8, H B 70885, I/A 27(21.02.17).

29 de Julio de 2015
Revocaciones. ADMINISTR.: FITO MORATO JAIME;FITO MORATO ANTONIO. Nombramientos. CONSEJERO: FITO MORATOANTONIO;FITO MORATO JAIME;FITO BAUCELLS ANTONI;FITO BAUCELLS EDUARD;FITO CASTELLS EULALIA;FITO BAUCELLSXAVIER;FITO CASTELLS ERNEST;FITO BAUCELLS ELISABETH. PRESIDENTE: FITO CASTELLS EULALIA. VICEPRESID.1: FITOBAUCELLS EDUARD. VICEPRESID.2: FITO BAUCELLS XAVIER. SECRETARIO: FITO BAUCELLS ANTONI. APODERAD.SOL: FITOBAUCELLS EDUARD;FITO BAUCELLS XAVIER;FITO CASTELLS EULALIA. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOSARTICULOS 12,13,20 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 43513 , F 103, S 8, H B 70885, I/A 25 (21.07.15).

05 de Junio de 2015
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION ART.19: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL.ADICION ART.19BIS: PENSION VITALICIA EN FAVOR DE LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD. Datos registrales. T43513 , F 103, S 8, H B 70885, I/A 24 (27.05.15).

10 de Febrero de 2015
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: GUASCH LOPEZ AUDITORES SLP. Datos registrales. T 43513 , F 102, S 8, H B 70885, I/A 22(30.01.15).

Nombramientos. AUDT.CTS.CON: GUASCH LOPEZ AUDITORES SLP. Datos registrales. T 43513 , F 103, S 8, H B 70885, I/A 23(30.01.15).

13 de Agosto de 2014
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 9.998.880,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.356.000,00 Euros. Datos registrales. T 43513, F 102, S 8, H B 70885, I/A 21 ( 5.08.14).

26 de Febrero de 2013
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 11.000.040,00 Euros. Resultante Suscrito: 14.354.880,00 Euros. Datos registrales. T43513 , F 101, S 8, H B 70885, I/A 20 (18.02.13).

24 de Diciembre de 2012
Nombramientos. AUDT.CTS.CON: GUASCH LOPEZ AUDITORES SL. Datos registrales. T 43513 , F 101, S 8, H B 70885, I/A 19(17.12.12).

13 de Diciembre de 2011
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: GUASCH LOPEZ AUDITORES SL. Datos registrales. T 24610 , F 97, S 8, H B 70885, I/A 18(30.11.11).

03 de Enero de 2011
Modificaciones estatutarias. ART.19:DETERMINACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL CARGO DE ADMINISTRADOR. Datosregistrales. T 24610 , F 97, S 8, H B 70885, I/A 17 (21.12.10).

21 de Junio de 2010
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 10.000.080,00 Euros. Resultante Suscrito: 25.354.920,00 Euros. Datos registrales. T24610 , F 96, S 8, H B 70885, I/A 16 ( 8.06.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n