Actos BORME de Productos Km. Zero Ii Sl
06 de Junio de 2023Nombramientos. Apoderado: CARRION ROMERA MARIA DEL CARMEN;PATRICIA SEIRE TREGINER;GODIA VILAESTER;VALERO VIDAL SILVIA;EXPOSITO MARTIN JOANA SILVIA;BULLICH FONTANET MERITXELL. Datos registrales. T 596 ,F 23, S 8, H L 11152, I/A 9 (30.05.23).
22 de Marzo de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: VIGATA CAMPO JOSE LUIS;VIGATA CAMPO JULIO FRANCISCO;VIGATA GONZALEZROLANDO. Nombramientos. Consejero: VIGATA CAMPO JULIO FRANCISCO;VIGATA GONZALEZ SILVIA;VIGATA GONZALEZROLANDO;VIGATA CAMPO JOSE LUIS. Presidente: VIGATA CAMPO JULIO FRANCISCO. Secretario: VIGATA GONZALEZ SILVIA.Cons.Del.Man: VIGATA CAMPO JULIO FRANCISCO;VIGATA GONZALEZ SILVIA;VIGATA GONZALEZ ROLANDO. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados a Consejo de administraci贸n. Datos registrales.T 596 , F 23, S 8, H L 11152, I/A 7 (14.03.17).
Nombramientos. Apoderado: VIGATA GONZALEZ ROLANDO. Datos registrales. T 596 , F 23, S 8, H L 11152, I/A 8 (15.03.17).
26 de Julio de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 33.625,95 Euros. Resultante Suscrito: 36.781,20 Euros. Datos registrales. T 596 , F 22, S 8, H L11152, I/A 6 (13.07.12).
17 de Marzo de 2010Nombramientos. Apo.Manc.: VIGATA ZARAGOZA JULIO;VIGATA GONZALEZ ROLANDO;VIGATA GONZALEZ SILVIA. Datosregistrales. T 596 , F 20, S 8, H L 11152, I/A 5 ( 5.03.10).