Buscador CIF Logo

Actos BORME Productos Quimicos Internacionales Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Productos Quimicos Internacionales Sa

Actos BORME Productos Quimicos Internacionales Sa - A29123494

Tenemos registrados 33 Actos BORME del Registro Mercantil de Malaga para Productos Quimicos Internacionales Sa con CIF A29123494

馃敊 Perfil de Productos Quimicos Internacionales Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Malaga

Actos BORME de Productos Quimicos Internacionales Sa

29 de Agosto de 2023
Reelecciones. Auditor: LEGAL AUDIT SL. Datos registrales. T 5874, L 4781, F 203, S 8, H MA 8390, I/A 49 (22.08.23).

23 de Marzo de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: RUEDA SOLER ANDRES. Apoderado: GUERVOS TUERO JUAN MANUEL. Nombramientos. Apoderado:MARTIN JIMENEZ JOSE. Datos registrales. T 5874, L 4781, F 203, S 8, H MA 8390, I/A 48 (15.03.22).

10 de Febrero de 2022
Nombramientos. Auditor: LEGAL AUDIT SL. Datos registrales. T 5874, L 4781, F 203, S 8, H MA 8390, I/A 47 (31.01.22).

17 de Septiembre de 2020
Nombramientos. Apoderado: MELLADO BLANCO JOSE LUIS. Datos registrales. T 5874, L 4781, F 202, S 8, H MA 8390, I/A 46(10.09.20).

06 de Agosto de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ SELVA ALEJANDRO;GONZALEZ SELVA MARIA DOLORES;GONZALEZ MELGAREJOJOSE MARIA. Presidente: GONZALEZ MELGAREJO JOSE MARIA. Secretario: GONZALEZ SELVA ALEJANDRO. Con.Delegado:GONZALEZ SELVA ALEJANDRO. Nombramientos. Adm. Unico: GONZALEZ SELVA ALEJANDRO. Otros conceptos: Cambio delOrgano de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Modificaci贸n parcial de Estatutos por cambio de 贸rganode administraci贸n, de Consejo de Administraci贸n a administrador 煤nico. Datos registrales. T 5874, L 4781, F 201, S 8, H MA 8390,I/A 44 (30.07.20).

Nombramientos. Apoderado: GUERVOS TUERO JUAN MANUEL. Datos registrales. T 5874, L 4781, F 202, S 8, H MA 8390, I/A 45(30.07.20).

22 de Junio de 2020
Reelecciones. Auditor: LEGAL AUDIT SL. Datos registrales. T 5874, L 4781, F 201, S 8, H MA 8390, I/A 43 (11.06.20).

06 de Noviembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: RUEDA SOLER ANDRES. Nombramientos. Apoderado: GARCIA SANCHEZ MANUEL. Datosregistrales. T 5540, L 4447, F 8, S 8, H MA 8390, I/A 42 (24.10.19).

03 de Septiembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ HERNANDEZ ANTONIO MIGUEL. Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ SELVAFRANCISCO JAVIER;RUEDA SOLER ANDRES. Datos registrales. T 5540, L 4447, F 8, S 8, H MA 8390, I/A 41 (26.08.19).

05 de Agosto de 2019
Revocaciones. Apo.Sol.: AGUILAR VERGARA PALMIRA. Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ HERNANDEZ ANTONIOMIGUEL. Datos registrales. T 5540, L 4447, F 8, S 8, H MA 8390, I/A 40 (26.07.19).

18 de Julio de 2019
Nombramientos. Con.Delegado: GONZALEZ SELVA ALEJANDRO. Otros conceptos: Se rectifica la escritura otorgada el 31-07-2017 ante el Notario de M谩laga don Jos茅 Andr茅s Navas Hidalgo, n潞 1.273 de orden, que caus贸 la inscripci贸n 27陋, al omitir que adem谩sde los acuerdos ya inscritos, se nombraba como Consejero Delegado por plazo de cinco a帽os, a don Alejandro Gonz谩lez Selva. Datosregistrales. T 5540, L 4447, F 7, S 8, H MA 8390, I/A 39 ( 9.07.19).

07 de Marzo de 2019
Reelecciones. Auditor: LEGAL AUDIT SL. Datos registrales. T 5540, L 4447, F 7, S 8, H MA 8390, I/A 38 (26.02.19).

26 de Febrero de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ BRAVO JAIME. Secretario: FERNANDEZ BRAVO JAIME. Presidente: GONZALEZSELVA ALEJANDRO. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ MELGAREJO JOSE MARIA. Presidente: GONZALEZ MELGAREJOJOSE MARIA. Secretario: GONZALEZ SELVA ALEJANDRO. Datos registrales. T 5540, L 4447, F 7, S 8, H MA 8390, I/A 37(18.02.19).

22 de Enero de 2019
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ BRAVO JAIME. Nombramientos. Apoderado: RUEDA SOLER ANDRES. Datosregistrales. T 5540, L 4447, F 7, S 8, H MA 8390, I/A 36 (10.01.19).

11 de Abril de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: OLIVER VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER. Secretario: OLIVER VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER.Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ BRAVO JAIME. Secretario: FERNANDEZ BRAVO JAIME. Datos registrales. T 5540, L4447, F 6, S 8, H MA 8390, I/A 34 ( 3.04.18).

Revocaciones. Apoderado: OLIVER VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ BRAVO JAIME.Datos registrales. T 5540, L 4447, F 6, S 8, H MA 8390, I/A 35 ( 3.04.18).

11 de Octubre de 2017
Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA GARCIA NOELIA. Datos registrales. T 5540, L 4447, F 6, S 8, H MA 8390, I/A 31 ( 2.10.17).

Revocaciones. Apoderado: MONTIEL JURADO SONIA. Datos registrales. T 5540, L 4447, F 6, S 8, H MA 8390, I/A 32 ( 3.10.17).

Revocaciones. Apo.Manc.: GONZALEZ SELVA ALEJANDRO;GONZALEZ SELVA JOSE MARIA. Datos registrales. T 5540, L 4447,F 6, S 8, H MA 8390, I/A 33 ( 3.10.17).

28 de Septiembre de 2017
Reelecciones. Consejero: GONZALEZ SELVA ALEJANDRO;GONZALEZ SELVA MARIA DOLORES. Presidente: GONZALEZ SELVAALEJANDRO. Datos registrales. T 5540, L 4447, F 5, S 8, H MA 8390, I/A 27 (19.09.17).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN JIMENEZ JOSE. Secretario: MARTIN JIMENEZ JOSE. Nombramientos. Secretario:OLIVER VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER. Consejero: OLIVER VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 5540, L 4447,F 5, S 8, H MA 8390, I/A 30 (19.09.17).

27 de Septiembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: MARTIN JIMENEZ JOSE. Apo.Sol.: MARTIN JIMENEZ JOSE. Datos registrales. T 5540, L 4447, F 5, S8, H MA 8390, I/A 29 (19.09.17).

26 de Septiembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: OLIVER VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 5540, L 4447, F 5, S 8, H MA 8390, I/A28 (19.09.17).

10 de Agosto de 2016
Nombramientos. Apo.Sol.: AGUILAR VERGARA PALMIRA;GARCIA GARCIA NOELIA. Datos registrales. T 3805, L 2716, F 206, S8, H MA 8390, I/A 26 (28.07.16).

09 de Junio de 2016
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 15.746,46 Euros. Resultante Suscrito: 299.664,69 Euros. Datos registrales. T 3805, L2716, F 206, S 8, H MA 8390, I/A 25 ( 1.06.16).

13 de Noviembre de 2015
Nombramientos. Apoderado: MONTIEL JURADO SONIA. Datos registrales. T 3805, L 2716, F 206, S 8, H MA 8390, I/A 24(29.10.15).

21 de Septiembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ MELGAREJO JOSE MARIA. Presidente: GONZALEZ MELGAREJO JOSE MARIA.Con.Delegado: GONZALEZ MELGAREJO JOSE MARIA. Secretario: GONZALEZ SELVA ALEJANDRO. Nombramientos. Consejero:MARTIN JIMENEZ JOSE. Secretario: MARTIN JIMENEZ JOSE. Presidente: GONZALEZ SELVA ALEJANDRO. Con.Delegado:GONZALEZ SELVA ALEJANDRO. Reelecciones. Auditor: LEGAL AUDIT SL. Datos registrales. T 3805, L 2716, F 205, S 8, H MA8390, I/A 23 (10.09.15).

14 de Agosto de 2014
Revocaciones. Apo.Sol.: PEREZ FERNANDEZ INES. Datos registrales. T 3805, L 2716, F 205, S 8, H MA 8390, I/A 21 ( 1.08.14).

25 de Junio de 2013
Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ FERNANDEZ INES;MARTIN JIMENEZ JOSE. Datos registrales. T 3805, L 2716, F 204, S 8, HMA 8390, I/A 19 (17.06.13).

Modificaciones estatutarias. Art铆culo 9潞.- . Datos registrales. T 3805, L 2716, F 205, S 8, H MA 8390, I/A 20 (17.06.13).

26 de Septiembre de 2011
Reelecciones. Consejero: GONZALEZ MELGAREJO JOSE MARIA. Presidente: GONZALEZ MELGAREJO JOSE MARIA. Consejero:GONZALEZ SELVA ALEJANDRO. Secretario: GONZALEZ SELVA ALEJANDRO. Consejero: GONZALEZ SELVA MARIA DOLORES.Con.Delegado: GONZALEZ MELGAREJO JOSE MARIA. Datos registrales. T 3805, L 2716, F 204, S 8, H MA 8390, I/A 17(14.09.11).

27 de Diciembre de 2010
Ceses/Dimisiones. Auditor: PARRONDO CARRETERO MANUEL;GARCIA MENDOZA JUAN JOSE. Nombramientos. Auditor:LEGAL AUDIT SL. Datos registrales. T 3805, L 2716, F 204, S 8, H MA 8390, I/A 16 (15.12.10).

23 de Enero de 2009
Nombramientos. Auditor: PARRONDO CARRETERO MANUEL;GARCIA MENDOZA JUAN JOSE. Datos registrales. T 3805, L2716, F 204, S 8, H MA 8390, I/A 15 (31.12.08).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n