Actos BORME de Profeico Atlantico Sl
11 de Agosto de 2023Ampliacion del objeto social. "Mensajería" y "Actividades auxiliares y complementarias del transporte". Datos registrales. T 4030, L4030, F 24, S 8, H PO 13817, I/A 23 ( 3.08.23).
27 de Febrero de 2023Reelecciones. Auditor: AB. AUDASO SL. Datos registrales. T 4030, L 4030, F 23, S 8, H PO 13817, I/A 22 (17.02.23).
14 de Julio de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GOMEZ FORTES GERMAN. Nombramientos. Adm. Unico: CARTERA BASE SL. Datosregistrales. T 4030, L 4030, F 23, S 8, H PO 13817, I/A 21 ( 6.07.22).
05 de Octubre de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: GOMEZ FORTES DORINDA. Apoderado: GOMEZ FORTES DORINDA. Datos registrales. T 4030, L4030, F 23, S 8, H PO 13817, I/A 20 (27.09.21).
27 de Enero de 2020Reelecciones. Auditor: AB. AUDASO SL. Datos registrales. T 4030, L 4030, F 23, S 8, H PO 13817, I/A 19 (14.01.20).
22 de Noviembre de 2018Reelecciones. Auditor: AB. AUDASO SL. Datos registrales. T 4030, L 4030, F 23, S 8, H PO 13817, I/A 18 (14.11.18).
11 de Enero de 2017Reelecciones. Auditor: AB. AUDASO SL. Datos registrales. T 4030, L 4030, F 23, S 8, H PO 13817, I/A 17 ( 2.01.17).
15 de Abril de 2016Revocaciones. Apoderado: GARCIA GONZALEZ MANUEL. Datos registrales. T 4030, L 4030, F 22, S 8, H PO 13817, I/A 16 (7.04.16).
20 de Enero de 2016Nombramientos. Auditor: AB. AUDASO SL. Datos registrales. T 4030, L 4030, F 22, S 8, H PO 13817, I/A 15 (13.01.16).
17 de Abril de 2015Nombramientos. Apoderado: PUENTE GOMEZ BEATRIZ. Datos registrales. T 1581, L 1581, F 138, S 8, H PO 13817, I/A 14 (8.04.15).
23 de Enero de 2015Ceses/Dimisiones. Auditor: AUDISER INTEGRAL SL. Nombramientos. Auditor: AB. AUDASO SL. Datos registrales. T 1581, L1581, F 138, S 8, H PO 13817, I/A 13 (15.01.15).
28 de Enero de 2014Nombramientos. Auditor: AUDISER INTEGRAL SL. Datos registrales. T 1581, L 1581, F 138, S 8, H PO 13817, I/A 12 (17.01.14).
03 de Abril de 2013Nombramientos. Auditor: FERNADEZ FERNANDEZ ALVARO. Datos registrales. T 1581, L 1581, F 138, S 8, H PO 13817, I/A 11(19.03.13).
10 de Abril de 2012Nombramientos. Apoderado: GOMEZ FORTES DORINDA. Datos registrales. T 1581, L 1581, F 137, S 8, H PO 13817, I/A 10(27.03.12).
21 de Junio de 2010Cambio de domicilio social. C/ ALCALDE GREGORIO ESPINO 34 BAJO (VIGO). Datos registrales. T 1, L 1581, F 137, S 8, H PO13817, I/A 9 ( 9.06.10).