Actos BORME de Profesionales De La Medicina Y De La Empresa Sa
16 de Noviembre de 2023Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 39598 , F 13, S 8, H M 132154, I/A 67 ( 8.11.23).
27 de Enero de 2023Revocaciones. Apoderado: BELTRAN GAMIR RAFAEL BJORN;BELTRAN GAMIR RAFAEL BJORN. Datos registrales. T 39598 , F13, S 8, H M 132154, I/A 66 (20.01.23).
19 de Enero de 2023Nombramientos. Apoderado: BELTRAN GAMIR RAFAEL BJORN. Datos registrales. T 39598 , F 12, S 8, H M 132154, I/A 65(12.01.23).
09 de Enero de 2023Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 39598 , F 11, S 8, H M 132154, I/A 64 (30.12.22).
27 de Octubre de 2022Revocaciones. Apoderado: GARCIA PEREZ ARANCHA. Datos registrales. T 39598 , F 11, S 8, H M 132154, I/A 63 (20.10.22).
07 de Enero de 2022Otros conceptos: Se estima la solicitud de la medida casutelar, acordando la anotaci贸n preventiva de la demanda interpuesta,respecto de la inscripci贸n n煤mero 58陋 de la hoja de la sociedad. Datos registrales. T 39598 , F 11, S 8, H M 132154, I/A A (30.12.21).
10 de Noviembre de 2021Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 39598 , F 10, S 8, H M 132154, I/A 62 ( 2.11.21).
27 de Julio de 2021Reelecciones. Consejero: GONZALEZ SERNA JUAN MANUEL. Datos registrales. T 39598 , F 10, S 8, H M 132154, I/A 61(20.07.21).
09 de Abril de 2021Nombramientos. Apoderado: BELTRAN GAMIR RAFAEL BJORN. Datos registrales. T 39598 , F 9, S 8, H M 132154, I/A 60 (2.04.21).
04 de Marzo de 2021Nombramientos. Apoderado: GARCIA PEREZ ARANCHA. Datos registrales. T 39598 , F 9, S 8, H M 132154, I/A 59 (25.02.21).
14 de Enero de 2021Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 554.560,73 Euros. Desembolsado: 554.560,73 Euros. Resultante Suscrito: 2.366.155,03 Euros.Resultante Desembolsado: 2.366.155,03 Euros. Datos registrales. T 39598 , F 3, S 8, H M 132154, I/A 58 ( 7.01.21).
07 de Octubre de 2020Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: ABARCA CIDON ALEJANDRO. Consejero: ABARCA CAMPAL JUAN;CIDON TAMARGOCARMEN. Reelecciones. Consejero: ABARCA CIDON JUAN;ABARCA CIDON ALEJANDRO. Presidente: ABARCA CIDON JUAN.Datos registrales. T 39598 , F 2, S 8, H M 132154, I/A 56 (30.09.20).
Modificaciones estatutarias. 6. Modificaci贸n de la redacci贸n de los art铆culos 6潞 y 22潞 de los estatutos sociales. . Datos registrales.T 39598 , F 2, S 8, H M 132154, I/A 57 (30.09.20).
07 de Julio de 2020Nombramientos. Apoderado: ARMENTA MARQUEZ LUIS. Datos registrales. T 39598 , F 1, S 8, H M 132154, I/A 55 (30.06.20).
22 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: ESTIRADO BRONCHALO ALBERTO. Datos registrales. T 39598 , F 1, S 8, H M 132154, I/A 54(15.06.20).
06 de Septiembre de 2019Reelecciones. Consejero: CIDON TAMARGO CARMEN;ABARCA CIDON ELENA;CONCHILLO ARMENDARIZ FEDERICO.Vicepresid.: ABARCA CIDON ELENA. Datos registrales. T 21715 , F 149, S 8, H M 132154, I/A 52 (30.08.19).
Modificaciones estatutarias. 15. Acciones/Participaciones.-. 32. Retribuci贸n.-. Datos registrales. T 21715 , F 149, S 8, H M 132154,I/A 53 (30.08.19).
26 de Diciembre de 2018Revocaciones. Auditor: EUDITA PERSEVIA AUDITORES DE CUENTAS SL. Aud.C.Con.: EUDITA PERSEVIA AUDITORES DECUENTAS SL. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 21715, F 148, S 8, H M 132154, I/A 51 (18.12.18).
30 de Mayo de 2018P谩gina web de la sociedad. Modificaci贸n de la p谩gina web corporativa.Nueva p谩gina web: www.hmhospitales.com. Datosregistrales. T 21715 , F 148, S 8, H M 132154, I/A 50 (22.05.18).
27 de Febrero de 2017Nombramientos. Apoderado: DIEZ ANDRES FLORENTINO. Datos registrales. T 21715 , F 148, S 8, H M 132154, I/A 49(20.02.17).
26 de Enero de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: CALDERON CALLEJA MARIA LUISA. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ SERNA JUANMANUEL. Datos registrales. T 21715 , F 148, S 8, H M 132154, I/A 48 (18.01.17).
25 de Enero de 2017Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 400.746,80 Euros. Desembolsado: 400.746,80 Euros. Resultante Suscrito: 1.811.594,30 Euros.Resultante Desembolsado: 1.811.594,30 Euros. Datos registrales. T 21715 , F 146, S 8, H M 132154, I/A 47 (17.01.17).
17 de Enero de 2017Nombramientos. Apoderado: ABARCA CIDON ELENA. Datos registrales. T 21715 , F 145, S 8, H M 132154, I/A 46 (10.01.17).
16 de Enero de 2017Cambio de domicilio social. PLAZA DEL CONDE DEL VALLE SUCHIL 2 (MADRID). Datos registrales. T 21715 , F 145, S 8, H M132154, I/A 44 ( 3.01.17).
Nombramientos. Apoderado: BELTRAN GAMIR RAFAEL BJORN. Datos registrales. T 21715 , F 145, S 8, H M 132154, I/A 45 (3.01.17).
03 de Octubre de 2016Reelecciones. Consejero: ABARCA CAMPAL JUAN. Auditor: EUDITA PERSEVIA AUDITORES DE CUENTAS SL. Aud.C.Con.:EUDITA PERSEVIA AUDITORES DE CUENTAS SL. Datos registrales. T 21715 , F 144, S 8, H M 132154, I/A 43 (23.09.16).
04 de Mayo de 2016Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: ABARCA CAMPAL JUAN. Presidente: ABARCA CAMPAL JUAN. Nombramientos. Presidente:ABARCA CIDON JUAN. Vicepresid.: ABARCA CIDON ELENA. Con.Delegado: ABARCA CIDON ALEJANDRO. Datos registrales. T21715 , F 144, S 8, H M 132154, I/A 42 (25.04.16).
07 de Abril de 2016Nombramientos. Apoderado: ARMENTA MARQUEZ LUIS. Datos registrales. T 21715 , F 144, S 8, H M 132154, I/A 41 (30.03.16).
21 de Septiembre de 2015Reelecciones. Consejero: ABARCA CIDON JUAN;ABARCA CIDON ALEJANDRO. Modificaciones estatutarias. MODIFICACIONDE LOS ARTICULOS 17,30 Y 34 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 21715 , F 142, S 8, H M 132154, I/A 40 (
19 de Agosto de 2014Nombramientos. Apoderado: ABARCA CIDON ELENA. Datos registrales. T 21715 , F 142, S 8, H M 132154, I/A 39 ( 8.08.14).
22 de Mayo de 2014Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: DELGADO SOLIS MANUEL. Consejero: DELGADO SOLIS MANUEL;VACHIANO LOPEZ CESAR.Nombramientos. Consejero: CIDON TAMARGO CARMEN;ABARCA CIDON ELENA;CALDERON CALLEJA MARIALUISA;CONCHILLO ARMENDARIZ FEDERICO. Datos registrales. T 21715 , F 141, S 8, H M 132154, I/A 38 (14.05.14).
13 de Enero de 2014Modificaciones estatutarias. 21. Funcionamiento Junta Gral.-. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa:www.hospitaldemadrid.com. Datos registrales. T 21715 , F 141, S 8, H M 132154, I/A 37 ( 2.01.14).
12 de Diciembre de 2013Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: PARKISA 2004 SA. Datos registrales. T 21715 , F 140, S 8, H M 132154, I/A 36 (4.12.13).
12 de Noviembre de 2013Reelecciones. Auditor: EUDITA PERSEVIA AUDITORES DE CUENTAS SL. Aud.C.Con.: EUDITA PERSEVIA AUDITORES DE
14 de Mayo de 2013Otros conceptos: Comunicacion de la insercion del proyecto de fusion de "Profesionales de la Medicina y de la Empresa, SA" y"Parkisa 2004, SA", en la pagina web corporativahttp://www.hmhospitales.com/grupohm/hmhospitales/Paginas/Rincon%20del%20Accionista/Rincon-del-Accionista-DocsPME.aspxdesde el 1-3-2103. Datos registrales. T 8190 , F 161, S 8, H M 132154, I/A 4 M (10.05.13).
11 de Abril de 2013Otros conceptos: PROYECTO DE FUSION FIRMADO FIRMADO EL 1 DE MARZO DE 2013 POR LOS ADMINISTRADORES DELAS SOCIEDADES INTERVINIENTES. LA SOCIEDAD PROFESIONALES DE LA MEDICINA Y DE LA EMPRESA SA, COMOSOCIEDAD ABSORBENTE Y PARKISA 2004 SA COMO SOCIEDAD ABSORBIDASustituido el dep贸sito de Proyecto de Fusi贸naprobado porel Consejo de 12 de septiembre de 2012, depositado el 28 denoviembre de 2012 con el n煤mero 18520/2012 de legajo.Datos registrales. T 8190 , F 160, S 8, H M 132154, I/A 4 M ( 2.04.13).
31 de Diciembre de 2012Reelecciones. Aud.C.Con.: EUDITA PERSEVIA AUDITORES DE CUENTAS SL. Auditor: EUDITA PERSEVIA AUDITORES DECUENTAS SL. Datos registrales. T 21715 , F 140, S 8, H M 132154, I/A 34 (20.12.12).
07 de Diciembre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: BLANQUE AVILES FRANCISCO JAVIER. Reelecciones. Consejero: VACHIANO LOPEZ CESAR.Datos registrales. T 21715 , F 139, S 8, H M 132154, I/A 33 (27.11.12).
18 de Junio de 2012Nombramientos. Apoderado: ABARCA CIDON ALEJANDRO. Datos registrales. T 21715 , F 138, S 8, H M 132154, I/A 32 (7.06.12).
27 de Febrero de 2012Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 22潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 21715 , F138, S 8, H M 132154, I/A 31 (14.02.12).
09 de Febrero de 2012Nombramientos. Apoderado: ABARCA CIDON ALEJANDRO. Datos registrales. T 21715 , F 137, S 8, H M 132154, I/A 30(30.01.12).
08 de Febrero de 2012Nombramientos. Apoderado: ABARCA CIDON ALEJANDRO. Datos registrales. T 21715 , F 135, S 8, H M 132154, I/A 27(27.01.12).
Ceses/Dimisiones. Presidente: DELGADO SOLIS MANUEL. Nombramientos. Presidente: ABARCA CAMPAL JUAN. Vicepresid.:DELGADO SOLIS MANUEL. Datos registrales. T 21715 , F 136, S 8, H M 132154, I/A 28 (27.01.12).
Ceses/Dimisiones. Consejero: HERNANDEZ NAVARRO MANUEL;PALACIO VALLELERSUNDI JOSE MARIA;ABARCA CIDONCARMEN;VIDAL PELAEZ JUAN JOSE. Nombramientos. Consejero: ABARCA CIDON ALEJANDRO;ABARCA CIDONJUAN;BLANQUE AVILES FRANCISCO JAVIER. Reelecciones. Consejero: VACHIANO LOPEZ CESAR;DELGADO SOLISMANUEL;ABARCA CAMPAL JUAN. Con.Delegado: ABARCA CAMPAL JUAN. Presidente: ABARCA CAMPAL JUAN. Auditor:PERSEVIA AUDITORES DE CUENTAS SL. Aud.C.Con.: PERSEVIA AUDITORES DE CUENTAS SL. Datos registrales. T 21715 , F136, S 8, H M 132154, I/A 29 (27.01.12).
19 de Octubre de 2010Nombramientos. Auditor: PERSEVIA AUDITORES DE CUENTAS SL. Aud.C.Con.: PERSEVIA AUDITORES DE CUENTAS SL.Datos registrales. T 21715 , F 135, S 8, H M 132154, I/A 26 ( 6.10.10).