Actos BORME de Progonzur Sociedad Limitada
16 de Marzo de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: VALERO NAVARRO JULIO JESUS. Nombramientos. Adm. Mancom.: VALERO NAVARROPEDRO JUAN. Datos registrales. T 703 , F 103, S 8, H CU 10473, I/A 3 ( 7.03.23).
22 de Agosto de 2016Cambio de domicilio social. C/ VIRGEN 22 (QUINTANAR DEL REY). Datos registrales. T 703 , F 102, S 8, H CU 10473, I/A 2(30.07.16).
21 de Julio de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GONZALEZ URREA MARIA DOLORES;GONZALEZ URREA MARIA ISABEL;GONZALEZ URREAJUAN CARLOS;URREA GONZALEZ JAVIER. Nombramientos. Adm. Mancom.: VALERO NAVARRO JULIO JESUS;VALERONAVARRO FERNANDO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administradoresmancomunados. Datos registrales. T 950, L 714, F 70, S 8, H AB 1796, I/A 6 (14.07.16).
05 de Mayo de 2015Nombramientos. Auditor: LOPEZ GOMEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 950, L 714, F 70, S 8, H AB 1796, I/A 5 (27.04.15).
19 de Diciembre de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GONZALEZ URREA ANTONIO;GONZALEZ URREA MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Adm.Solid.: GONZALEZ URREA MARIA DOLORES;GONZALEZ URREA MARIA ISABEL;GONZALEZ URREA JUAN CARLOS;URREAGONZALEZ JAVIER. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados aAdministradores solidarios. Cambio de domicilio social. C/ ROSARIO 88 4 DR - CODIGO POSTAL 02003 (ALBACETE). Datosregistrales. T 605, L 369, F 13, S 8, H AB 1796, I/A 4 (12.12.14).
03 de Septiembre de 2013Cambio de objeto social. Administrar los bienes de los socios - Administradores Patrimoniales - Datos registrales. T 605, L 369, F13, S 8, H AB 1796, I/A 3 (28.08.13).