Actos BORME de Proindumar Sl
17 de Octubre de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: RUIZ ZAPATA JOSE LUIS. Nombramientos. Adm. Unico: ORENES RODRIGUEZ ELISEO. Datosregistrales. T 28690 , F 138, S 8, H M 63699, I/A 29 ( 7.10.22).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ CERRON FRANCISCO JAVIER;YEPES RODRIGUEZ ANGEL LUIS;GARCIA CUESTASPEDRO;ZAPLANA PARDO PEDRO ANTONIO. Apo.Sol.: ALARCON CASTILLO FELIX MANUEL. Apo.Man.Soli: RUIZ ZAPATA JOSELUIS;GONZALEZ VALVERDE JOSE LUIS;FUENTES MORALEDA AURELIO. Datos registrales. T 28690 , F 138, S 8, H M 63699,I/A 30 ( 7.10.22).
Nombramientos. Apo.Manc.: RUIZ ZAPATA JOSE LUIS;PEREZ HUALDE LEILA;MU脩OZ GARRIDO IVONNE;ESTRINGANACASTILLO YOLANDA. Datos registrales. T 28690 , F 140, S 8, H M 63699, I/A 31 ( 7.10.22).
17 de Agosto de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: YEPES RODRIGUEZ ANGEL LUIS;GONZALEZ VALVERDE JOSE LUIS. Datos registrales. T 28690 , F138, S 8, H M 63699, I/A 28 ( 9.08.22).
16 de Agosto de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FRANCO MU脩OZ JESUS. Nombramientos. Adm. Unico: RUIZ ZAPATA JOSE LUIS. Datosregistrales. T 28690 , F 137, S 8, H M 63699, I/A 26 ( 8.08.22).
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: RECREATIVOS FRANCO SA. Datos registrales. T 28690 , F 137, S 8, H M 63699,I/A 27 ( 8.08.22).
12 de Agosto de 2022Revocaciones. Apoderado: PEREZ SILVA ELVIRA. Datos registrales. T 28690 , F 137, S 8, H M 63699, I/A 25 ( 5.08.22).
01 de Abril de 2022Revocaciones. Apoderado: PALOMERO SEGOVIA JOSE MARIANO. Datos registrales. T 28690 , F 137, S 8, H M 63699, I/A 24(25.03.22).
27 de Diciembre de 2021Revocaciones. Apoderado: SEGOVIA VARGAS MANUEL. Datos registrales. T 28690 , F 137, S 8, H M 63699, I/A 23 (20.12.21).
05 de Agosto de 2021Nombramientos. Apoderado: PEREZ SILVA ELVIRA. Datos registrales. T 28690 , F 136, S 8, H M 63699, I/A 21 (29.07.21).
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ NAVAMUEL MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 28690 , F 137, S 8, H M 63699, I/A 22(29.07.21).
17 de Octubre de 2018Revocaciones. Apoderado: FRANCO PEREZ MARIA- NIEVES;FRANCO PEREZ JOAQUIN. Datos registrales. T 28690 , F 136, S8, H M 63699, I/A 20 ( 9.10.18).
28 de Noviembre de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: MELENDO DERQUI PEDRO-PABLO. Datos registrales. T 28690 , F 136, S 8, H M 63699, I/A 19(20.11.17).
01 de Julio de 2016Nombramientos. Apoderado: SEGOVIA VARGAS MANUEL. Datos registrales. T 28690 , F 135, S 8, H M 63699, I/A 18 (23.06.16).
15 de Noviembre de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: MELENDO DERQUI PEDRO-PABLO. Datos registrales. T 28690 , F 134, S 8, H M 63699, I/A 17 (7.11.13).
16 de Agosto de 2011Nombramientos. Apoderado: PALOMERO SEGOVIA JOSE MARIANO. Datos registrales. T 3787 , F 225, S 8, H M 63699, I/A 16 (1.08.11).
01 de Junio de 2011Revocaciones. Apoderado: CARRO CALLEJA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 3787 , F 225, S 8, H M 63699, I/A 15(20.05.11).
20 de Abril de 2010Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: FRANCO MU脩OZ JOAQUIN;FRANCO MU脩OZ JESUS. Nombramientos. Adm. Unico: FRANCOMU脩OZ JESUS. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administrador煤nico. Datos registrales. T 3787 , F 224, S 8, H M 63699, I/A 14 ( 8.04.10).