Buscador CIF Logo

Actos BORME Proindumar Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Proindumar Sl

Actos BORME Proindumar Sl - B80438831

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Proindumar Sl con CIF B80438831

馃敊 Perfil de Proindumar Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Proindumar Sl

17 de Octubre de 2022
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: RUIZ ZAPATA JOSE LUIS. Nombramientos. Adm. Unico: ORENES RODRIGUEZ ELISEO. Datosregistrales. T 28690 , F 138, S 8, H M 63699, I/A 29 ( 7.10.22).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ CERRON FRANCISCO JAVIER;YEPES RODRIGUEZ ANGEL LUIS;GARCIA CUESTASPEDRO;ZAPLANA PARDO PEDRO ANTONIO. Apo.Sol.: ALARCON CASTILLO FELIX MANUEL. Apo.Man.Soli: RUIZ ZAPATA JOSELUIS;GONZALEZ VALVERDE JOSE LUIS;FUENTES MORALEDA AURELIO. Datos registrales. T 28690 , F 138, S 8, H M 63699,I/A 30 ( 7.10.22).

Nombramientos. Apo.Manc.: RUIZ ZAPATA JOSE LUIS;PEREZ HUALDE LEILA;MU脩OZ GARRIDO IVONNE;ESTRINGANACASTILLO YOLANDA. Datos registrales. T 28690 , F 140, S 8, H M 63699, I/A 31 ( 7.10.22).

17 de Agosto de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: YEPES RODRIGUEZ ANGEL LUIS;GONZALEZ VALVERDE JOSE LUIS. Datos registrales. T 28690 , F138, S 8, H M 63699, I/A 28 ( 9.08.22).

16 de Agosto de 2022
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FRANCO MU脩OZ JESUS. Nombramientos. Adm. Unico: RUIZ ZAPATA JOSE LUIS. Datosregistrales. T 28690 , F 137, S 8, H M 63699, I/A 26 ( 8.08.22).

Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: RECREATIVOS FRANCO SA. Datos registrales. T 28690 , F 137, S 8, H M 63699,I/A 27 ( 8.08.22).

12 de Agosto de 2022
Revocaciones. Apoderado: PEREZ SILVA ELVIRA. Datos registrales. T 28690 , F 137, S 8, H M 63699, I/A 25 ( 5.08.22).

01 de Abril de 2022
Revocaciones. Apoderado: PALOMERO SEGOVIA JOSE MARIANO. Datos registrales. T 28690 , F 137, S 8, H M 63699, I/A 24(25.03.22).

27 de Diciembre de 2021
Revocaciones. Apoderado: SEGOVIA VARGAS MANUEL. Datos registrales. T 28690 , F 137, S 8, H M 63699, I/A 23 (20.12.21).

05 de Agosto de 2021
Nombramientos. Apoderado: PEREZ SILVA ELVIRA. Datos registrales. T 28690 , F 136, S 8, H M 63699, I/A 21 (29.07.21).

Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ NAVAMUEL MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 28690 , F 137, S 8, H M 63699, I/A 22(29.07.21).

17 de Octubre de 2018
Revocaciones. Apoderado: FRANCO PEREZ MARIA- NIEVES;FRANCO PEREZ JOAQUIN. Datos registrales. T 28690 , F 136, S8, H M 63699, I/A 20 ( 9.10.18).

28 de Noviembre de 2017
Revocaciones. Apo.Sol.: MELENDO DERQUI PEDRO-PABLO. Datos registrales. T 28690 , F 136, S 8, H M 63699, I/A 19(20.11.17).

01 de Julio de 2016
Nombramientos. Apoderado: SEGOVIA VARGAS MANUEL. Datos registrales. T 28690 , F 135, S 8, H M 63699, I/A 18 (23.06.16).

15 de Noviembre de 2013
Nombramientos. Apo.Sol.: MELENDO DERQUI PEDRO-PABLO. Datos registrales. T 28690 , F 134, S 8, H M 63699, I/A 17 (7.11.13).

16 de Agosto de 2011
Nombramientos. Apoderado: PALOMERO SEGOVIA JOSE MARIANO. Datos registrales. T 3787 , F 225, S 8, H M 63699, I/A 16 (1.08.11).

01 de Junio de 2011
Revocaciones. Apoderado: CARRO CALLEJA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 3787 , F 225, S 8, H M 63699, I/A 15(20.05.11).

20 de Abril de 2010
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: FRANCO MU脩OZ JOAQUIN;FRANCO MU脩OZ JESUS. Nombramientos. Adm. Unico: FRANCOMU脩OZ JESUS. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administrador煤nico. Datos registrales. T 3787 , F 224, S 8, H M 63699, I/A 14 ( 8.04.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n