Actos BORME de Prologis Spain Management Ii Sl
18 de Enero de 2016Revocaciones. APODERADO: GUSTAVO ALBERTO CARDOZO;PHILIP DUNNE;DAVID DOYLE;PETER CASSELLS;ANTOON VANOMMEREN;GERRIT JAN MEERKERK;ALBERT CORNELIS TOL;JOHN CORBET;CHRISTIAN NICKELS TESKE;DANNIS VAN DERGEER;ANTOINE BERALDI;KAREN LEE;GUSTAVO CARDOZO;GARETH GREGORY;ANDREW SLOAN. Extinci贸n. Datosregistrales. T 37673 , F 109, S 8, H B 258920, I/A 18 ( 8.01.16).
17 de Julio de 2015Cambio de domicilio social. PZ EUROPA,9-11, PLANTA 12 (MODULOS A Y D) (HOSPITALET DE LLOBREGAT (L'). Datosregistrales. T 37673 , F 109, S 8, H B 258920, I/A 17 ( 9.07.15).
02 de Julio de 2013Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: KAREN JANE LEE. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: LAURENCE CUVELIER. Datosregistrales. T 37673 , F 109, S 8, H B 258920, I/A 16 (21.06.13).
04 de Enero de 2012Revocaciones. APODERADO: CHRISTOPHE HAMON. Datos registrales. T 37673 , F 109, S 8, H B 258920, I/A 15 (23.12.11).
15 de Septiembre de 2011Revocaciones. APODERADO: RANALD HAHN. Datos registrales. T 37673 , F 109, S 8, H B 258920, I/A 14 ( 5.09.11).
07 de Septiembre de 2011Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: RANALD ALEXANDER HAHN;PETER G CASSELLS. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.:FRANCOIS JEAN RISPE;KAREN JANE LEE. Datos registrales. T 37673 , F 108, S 8, H B 258920, I/A 13 (26.08.11).
18 de Noviembre de 2010Nombramientos. APODERADO: PHILIP DUNNE;DAVID DOYLE;PETER CASSELLS;ANTOON VAN OMMEREN;GERRIT JANMEERKERK;ALBERT CORNELIS TOL;JOHN CORBET;CHRISTIAN NICKELS TESKE;RANALD HAHN;DANNIS VAN DERGEER;ANTOINE BERALDI;KAREN LEE;GUSTAVO CARDOZO;GARETH GREGORY;ANDREW SLOAN;CHRISTOPHE HAMON.Datos registrales. T 37673 , F 106, S 8, H B 258920, I/A 12 ( 8.11.10).
19 de Octubre de 2010Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: LINDA HELENA MARIA VAN VELZEN. Datos registrales. T 37673 , F 106, S 8, H B 258920, I/A 11( 6.10.10).
20 de Marzo de 2009Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: LINDA HELENA MARIA VAN VELZEN. Datos registrales. T 37673 , F 106, S 8, H B 258920, I/A10 ( 9.03.09).