Buscador CIF Logo

Actos BORME Prologis Spain Management Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Prologis Spain Management Sl

Actos BORME Prologis Spain Management Sl - B62080890

Tenemos registrados 24 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Prologis Spain Management Sl con CIF B62080890

馃敊 Perfil de Prologis Spain Management Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Prologis Spain Management Sl

26 de Enero de 2023
Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: PROLOGIS BV. REPR.143 RRM: GARETH ALAN GREGORY. Datos registrales. T 46053 , F 137,S 8, H B 207250, I/A 44 (19.01.23).

13 de Diciembre de 2022
Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: GAETAN PASTOL. Datos registrales. T 46053 , F 137, S 8, H B 207250, I/A 43 ( 1.12.22).

25 de Octubre de 2022
Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: LAURENCE CUVELIER. Datos registrales. T 46053 , F 137, S 8, H B 207250, I/A 42 (18.10.22).

23 de Marzo de 2021
Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: FRANCOIS JEAN RISPE. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: CECILE TRICAULT. Datosregistrales. T 46053 , F 137, S 8, H B 207250, I/A 41 (12.03.21).

03 de Diciembre de 2020
Nombramientos. AUDIT.INDIV.: KPGM AUDITORES SL. Datos registrales. T 46053 , F 137, S 8, H B 207250, I/A 40 (26.11.20).

23 de Diciembre de 2019
Revocaciones. APODERADO: GUSTAVO ALBERTO CARDOZO. Datos registrales. T 46053 , F 136, S 8, H B 207250, I/A 38(13.12.19).

Revocaciones. APOD.MANCOMU: MAGDALENA DAGMARA STACHOWICZ. Nombramientos. APOD.MANCOMU: PIOTRMACIEJ ADAMUS. Datos registrales. T 46053 , F 136, S 8, H B 207250, I/A 39 (13.12.19).

02 de Diciembre de 2019
Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: CARDOZO LUPI GUSTAVO ALBERTO. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: OLLER ANGUSTO

06 de Marzo de 2018
Revocaciones. APODERADO: PHILIP DUNNE;DAVID DOYLE;PETER CASSELLS;ANTOON VAN OMMEREN;GERRIT JANMEERKERK;ALBERT CORNELIS TOL;JOHN CORBET;CHRISTIAN NICKELS TESKE;DENNIS VAN DER GEER;ANTOINEBERALDI;KAREN LEE;GUSTAVO CARDOZO;GARETH GREGORY;ANDREW SLOAN. Datos registrales. T 46053 , F 135, S 8, H B207250, I/A 35 (26.02.18).

Revocaciones. APODERADO: RODRIGUEZ TITOS DIEGO;DE SANTIAGO TORRENTE OSCAR;PEREZ BREVA JOSE ANTONIO.Datos registrales. T 46053 , F 135, S 8, H B 207250, I/A 36 (26.02.18).

01 de Septiembre de 2017
Nombramientos. APOD.MANCOMU: JOHAN LEENDERT HOESTRA;IAIN ANDREW CURRIE;MAGDALENA DAGMARASTACHOWICZ. Datos registrales. T 46053 , F 135, S 8, H B 207250, I/A 34 (21.08.17).

28 de Octubre de 2016
Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: PROLOGIS BV. REPR.143 RRM: GARETH ALAN GREGORY. Datos registrales. T 39328 , F160, S 8, H B 207250, I/A 33 (21.10.16).

13 de Mayo de 2016
Otros conceptos: ASIGNACION DE NUMERO DE DNI AL ADMINISTRADOR SOLIDARIO DON GUSTAVO ALBERTOCARDOZO,FIGURANDO EN ADELANTE COMO "GUSTAVO ALBERTO CARDOZO LUPI". Datos registrales. T 39328 , F 160, S 8,H B 207250, I/A 32 ( 5.05.16).

18 de Enero de 2016
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Fusi贸n por absorci贸n.Sociedades absorbidas: PROLOGIS SPAIN MANAGEMENT II SL. Datos registrales. T 39328 , F 156, S 8, H B 207250, I/A 31 (8.01.16).

20 de Julio de 2015
Cambio de domicilio social. PZ EUROPA,9-11, PLANTA 12 (MODULOS A Y D) (HOSPITALET DE LLOBREGAT (L'). Datosregistrales. T 39328 , F 156, S 8, H B 207250, I/A 30 ( 9.07.15).

01 de Julio de 2013
Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: KAREN JANE LEE. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: LAURENCE CUVELIER. Datosregistrales. T 39328 , F 156, S 8, H B 207250, I/A 29 (21.06.13).

03 de Enero de 2012
Revocaciones. APODERADO: CHRISTOPHE HAMON. Datos registrales. T 39328 , F 155, S 8, H B 207250, I/A 27 (22.12.11).

Revocaciones. APODERADO: CHRISTOPHE HAMON. Datos registrales. T 39328 , F 156, S 8, H B 207250, I/A 28 (22.12.11).

15 de Septiembre de 2011
Revocaciones. APODERADO: RANALD HAHN. Datos registrales. T 39328 , F 155, S 8, H B 207250, I/A 26 ( 5.09.11).

07 de Septiembre de 2011
Revocaciones. ADMINISTR.: RANALD ALEXANDER HAHN. ADM.SOLIDAR.: PETER G CASSELLS. Nombramientos.ADM.SOLIDAR.: FRANCOIS JEAN RISPE;KAREN JANE LEE. Datos registrales. T 39328 , F 154, S 8, H B 207250, I/A 25(26.08.11).

18 de Noviembre de 2010
Nombramientos. APODERADO: PHILIP DUNNE;DAVID DOYLE;PETER CASSELLS;ANTOON VAN OMMEREN;GERRIT JANMEERKERK;ALBERT CORNELIS TOL;JOHN CORBET;CHRISTIAN NICKELS TESKE;RANALD HAHN;DENNIS VAN DERGEER;ANTOINE BERALDI;KAREN LEE;CHRISTOPHE HAMON;GUSTAVO CARDOZO;GARETH GREGORY;ANDREW SLOAN.Datos registrales. T 39328 , F 153, S 8, H B 207250, I/A 24 ( 8.11.10).

19 de Octubre de 2010
Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: LINDA HELENA MARIA VAN VELZEN. Datos registrales. T 39328 , F 153, S 8, H B 207250, I/A 23( 6.10.10).

20 de Marzo de 2009
Revocaciones. APODERADO: DAVID BOYER. Datos registrales. T 39328 , F 153, S 8, H B 207250, I/A 21 ( 9.03.09).

Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: LINDA HELENA MARIA VAN VELZEN. Datos registrales. T 39328 , F 153, S 8, H B 207250, I/A22 ( 9.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n