Buscador CIF Logo

Actos BORME Prologis Spain Xv Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Prologis Spain Xv Sl

Actos BORME Prologis Spain Xv Sl - B63920631

Tenemos registrados 23 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Prologis Spain Xv Sl con CIF B63920631

馃敊 Perfil de Prologis Spain Xv Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Prologis Spain Xv Sl

26 de Enero de 2023
Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: PROLOGIS EUROPEAN DEVELOPMENTS BV SL. REPR.143 RRM: GARETH ALAN GREGORY.Datos registrales. T 42954 , F 7, S 8, H B 315313, I/A 27 (19.01.23).

13 de Diciembre de 2022
Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: GAETAN PASTOL. Datos registrales. T 42954 , F 7, S 8, H B 315313, I/A 26 ( 1.12.22).

25 de Octubre de 2022
Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: LAURENCE CUVELIER. Datos registrales. T 42954 , F 7, S 8, H B 315313, I/A 25 (18.10.22).

25 de Enero de 2022
Ampliaci贸n de capital. Capital: 500,00 Euros. Resultante Suscrito: 804.000,00 Euros. Datos registrales. T 42954 , F 6, S 8, H B

23 de Marzo de 2021
Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: FRANCOIS JEAN RISPE. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: CECILE TRICAULT. Datosregistrales. T 42954 , F 6, S 8, H B 315313, I/A 23 (15.03.21).

14 de Enero de 2021
Ampliaci贸n de capital. Capital: 300.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 803.500,00 Euros. Datos registrales. T 42954 , F 5, S 8, H B315313, I/A 22 ( 5.01.21).

26 de Diciembre de 2019
Revocaciones. APODERADO: GUSTAVO ALBERTO CARDOZO. Datos registrales. T 42954 , F 5, S 8, H B 315313, I/A 20(18.12.19).

Revocaciones. APOD.MANCOMU: MAGDALENA DAGMARA STACHOWICZ. Nombramientos. APOD.MANCOMU: PIOTRMACIEJ ADAMUS. Datos registrales. T 42954 , F 5, S 8, H B 315313, I/A 21 (18.12.19).

05 de Diciembre de 2019
Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: CARDOZO LUPI GUSTAVO ALBERTO. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: OLLER ANGUSTOCRISTIAN. Datos registrales. T 42954 , F 4, S 8, H B 315313, I/A 19 (28.11.19).

02 de Marzo de 2018
Revocaciones. APODERADO: PHILIP DUNNE;DAVID DOYLE;PETER CASSELLS;ANTOON VAN OMMEREN;GERRIT JANMEERKERK;ALBERT CORNELIS TOL;JOHN CORBET;CHRISTIAN NICKELS TESKE;DENNIS VAN DER GEER;ANTOINEBERALDI;KAREN LEE;GUSTAVO CARDOZO;GARETH GREGORY;ANDREW SLOAN. Datos registrales. T 42954 , F 4, S 8, H B315313, I/A 18 (23.02.18).

14 de Febrero de 2017
Nombramientos. APOD.MANCOMU: MAGDALENA DAGMARA STACHOWICZ. Datos registrales. T 42954 , F 4, S 8, H B 315313,I/A 17 ( 3.02.17).

13 de Septiembre de 2016
Revocaciones. REPR.143 RRM: ALBERT CORNELIS TOL. Nombramientos. REPR.143 RRM: GARETH ALAN GREGORY. Datosregistrales. T 42954 , F 4, S 8, H B 315313, I/A 16 ( 5.09.16).

13 de Mayo de 2016
Otros conceptos: ASIGNACION DE NUMERO DE DNI AL ADMINISTRADOR SOLIDARIO DON GUSTAVO ALBERTO CARDOZO,FIGURANDO EN ADELANTE COMO "GUSTAVO ALBERTO CARDOZO LUPI". Datos registrales. T 42954 , F 3, S 8, H B 315313,I/A 15 ( 5.05.16).

22 de Diciembre de 2015
Nombramientos. APOD.MANCOMU: JOHAN LEENDERT HOESTRA;IAIN ANDREW CURRIE. Datos registrales. T 42954 , F 3, S8, H B 315313, I/A 14 (14.12.15).

23 de Abril de 2015
Cambio de domicilio social. PZ EUROPA, 9-11, PLANTA 12 (MODULOS A Y D) (HOSPITALET DE LLOBREGAT (L'). Datosregistrales. T 42954 , F 3, S 8, H B 315313, I/A 13 (16.04.15).

01 de Julio de 2013
Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: KAREN JANE LEE. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: LAURENCE CUVELIER. Datosregistrales. T 42954 , F 2, S 8, H B 315313, I/A 12 (21.06.13).

30 de Agosto de 2012
Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: PROLOGIS SPAIN XV SARL. REPR.143 RRM: PETER G CASSELLS. Nombramientos.ADM.SOLIDAR.: PROLOGIS EUROPEAN DEVELOPMENTS BV SL. REPR.143 RRM: ALBERT CORNELIS TOL. Datos registrales.T 42954 , F 2, S 8, H B 315313, I/A 11 (21.08.12).

13 de Agosto de 2012
Otros conceptos: CAMBIO DE SOCIO UNICO.NUEVO SOCIO UNICO:PROLOGIS EUROPEAN DEVELOPMENTS BV. Datosregistrales. T 42954 , F 2, S 8, H B 315313, I/A 10 ( 1.08.12).

04 de Enero de 2012
Revocaciones. APODERADO: CHRISTOPHE HAMON. Datos registrales. T 42954 , F 1, S 8, H B 315313, I/A 9 (23.12.11).

14 de Octubre de 2011
Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: PETER G CASELLS;RANALD ALEXANDER HAHN. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.:FRANCOIS JEAN RISPE;KAREN JANE LEE;PROLOGIS SPAIN XV SARL. REPR.143 RRM: PETER G CASSELLS. Datosregistrales. T 37850 , F 17, S 8, H B 315313, I/A 7 ( 3.10.11).

Revocaciones. APODERADO: RANALD HAHN. Datos registrales. T 42954 , F 1, S 8, H B 315313, I/A 8 ( 3.10.11).

18 de Noviembre de 2010
Nombramientos. APODERADO: PHILIP DUNNE;DAVID DOYLE;PETER CASSELLS;ANTOON VAN OMMEREN;GERRIT JAN

03 de Diciembre de 2009
Ampliaci贸n de capital. Capital: 500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 503.500,00 Euros. Datos registrales. T 37850 , F 15, S 8, HB 315313, I/A 5 (20.11.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n