Actos BORME de Prominent Iberia Sa
07 de Diciembre de 2023Nombramientos. Apoderado: RICARDO SCARPIONI DE BENEDETTO. Datos registrales. T 3334 , F 65, S 8, H GI 5162, I/A 38(29.11.23).
11 de Agosto de 2023Nombramientos. Apoderado: RICARDO SCARPIONI DE BENEDETTO. Datos registrales. T 3334 , F 64, S 8, H GI 5162, I/A 37 (4.08.23).
31 de Mayo de 2022Nombramientos. Apo.D.Gral.: RICARDO SCARPIONI DE BENEDETTO. Datos registrales. T 3334 , F 64, S 8, H GI 5162, I/A 36(24.05.22).
18 de Agosto de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: THOMAS ALEXANDER KOETZING. Presidente: THOMAS ALEXANDER KOETZING. Consejero:JOSEP GUSSINYER GALCERAN. Secretario: JOSEP GUSSINYER GALCERAN. Consejero: JOAQUIM DANIEL MOREIRARAMALHO BARTOLO. Revocaciones. Apoderado: JOSEP GUSSINYER GALCERAN. Apo.Man.Soli: JOSEP GUSSINYERGALCERAN;THOMAS ALEXANDER KOETZING. Nombramientos. Adm. Solid.: JOAQUIM DANIEL MOREIRA RAMALHOBARTOLO;MICHAEL BENEDIKT NAGEL. Modificaciones estatutarias. trador ser谩 de seis a帽os. Otros conceptos: Cambio delOrgano de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Aprobaci贸n de unos nuevos estatutos sociales deconformidad con la Ley de Sociedades de Capital. Datos registrales. T 2949 , F 220, S 8, H GI 5162, I/A 35 (10.08.21).
26 de Mayo de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: JOAQUIM DANIEL MOREIRA RAMALHO BARTOLO. Datos registrales. T 2949 , F 220, S 8, H GI5162, I/A 34 (19.05.21).
28 de Abril de 2021Revocaciones. Apoderado: JOSEP MARIA GUSSINYER CANADELL. Apo.Sol.: FRIEDRICH HARTMANN;ENRIQUETA GALCERANVILA. Apoderado: ENRIQUETA GALCERAN VILA. Apo.Sol.: ANNA CUEVAS SENPAU. Datos registrales. T 2949 , F 219, S 8, H GI5162, I/A 33 (21.04.21).
07 de Enero de 2021Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2949 , F 219, S 8, H GI 5162, I/A 32 (29.12.20).
08 de Junio de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: ANDREAS ZACHARIAS JOHANNE DULGER. Presidente: ANDREAS ZACHARIAS JOHANNEDULGER. Consejero: JOSEP GUSSINYER GALCERAN. Secretario: JOSEP GUSSINYER GALCERAN. Consejero: JOAQUIM DANIELMOREIRA RAMALHO BARTOLO. Revocaciones. Apo.Man.Soli: ANDREAS ZACHARIAS JOHANNE DULGER;JOSEP GUSSINYERGALCERAN. Nombramientos. Consejero: THOMAS ALEXANDER KOETZING. Presidente: THOMAS ALEXANDER KOETZING.Consejero: JOSEP GUSSINYER GALCERAN. Secretario: JOSEP GUSSINYER GALCERAN. Consejero: JOAQUIM DANIELMOREIRA RAMALHO BARTOLO. Apo.Man.Soli: JOSEP GUSSINYER GALCERAN;THOMAS ALEXANDER KOETZING. Datosregistrales. T 2949 , F 219, S 8, H GI 5162, I/A 31 (30.05.18).
26 de Marzo de 2018Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2949 , F 219, S 8, H GI 5162, I/A 30 (19.03.18).
12 de Enero de 2016Ceses/Dimisiones. Gerente: VICTOR DULGER;JOSEP GUSSINYER GALCERAN. Consejero: VICTOR DULGER. Presidente:VICTOR DULGER. Consejero: JOSEP GUSSINYER GALCERAN. Secretario: JOSEP GUSSINYER GALCERAN. Consejero:ANDREAS ZACHARIAS JOHANNE DULGER. Nombramientos. Consejero: ANDREAS ZACHARIAS JOHANNE DULGER.Presidente: ANDREAS ZACHARIAS JOHANNE DULGER. Consejero: JOSEP GUSSINYER GALCERAN. Secretario: JOSEPGUSSINYER GALCERAN. Consejero: JOAQUIM DANIEL MOREIRA RAMALHO BARTOLO. Apo.Man.Soli: ANDREAS ZACHARIASJOHANNE DULGER;JOSEP GUSSINYER GALCERAN. Datos registrales. T 277 , F 174, S 8, H GI 5162, I/A 29 (30.12.15).
27 de Octubre de 2014Ceses/Dimisiones. Auditor: AUDITORIA I CONTROL AUDITORS SLP. Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datosregistrales. T 277 , F 174, S 8, H GI 5162, I/A 28 (16.10.14).
11 de Agosto de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: ANNA CUEVAS SENPAU. Datos registrales. T 277 , F 174, S 8, H GI 5162, I/A 27 ( 1.08.14).
25 de Julio de 2012Revocaciones. Apoderado: EDUARDO RIGAU BOSCH. Datos registrales. T 277 , F 174, S 8, H GI 5162, I/A 26 (11.07.12).
18 de Junio de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: VICTOR DULGER;JOSEP GUSSINYER GALCERAN;ENRIQUETA GALCERAN VILA;ANDREAS Z.JOHANNES DULGER. Presidente: VICTOR DULGER. Secretario: JOSEP GUSSINYER GALCERAN. Revocaciones. Apo.Man.Soli:JOSEP GUSSINYER GALCERAN;VICTOR DULGER. Nombramientos. Consejero: VICTOR DULGER. Presidente: VICTORDULGER. Consejero: JOSEP GUSSINYER GALCERAN. Secretario: JOSEP GUSSINYER GALCERAN. Consejero: ANDREAS Z.JOHANNES DULGER. Gerente: VICTOR DULGER;JOSEP GUSSINYER GALCERAN. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 236.012,70Euros. Desembolsado: 236.012,70 Euros. Resultante Suscrito: 608.632,70 Euros. Resultante Desembolsado: 608.632,70 Euros.Datos registrales. T 277 , F 173, S 8, H GI 5162, I/A 25 ( 4.06.12).
23 de Agosto de 2010Nombramientos. Auditor: AUDITORIA I CONTROL AUDITORS SLP. Datos registrales. T 277 , F 172, S 8, H GI 5162, I/A 24(12.08.10).
17 de Noviembre de 2009Nombramientos. Apoderado: EDUARDO RIGAU BOSCH. Datos registrales. T 277 , F 172, S 8, H GI 5162, I/A 23 ( 5.11.09).