Actos BORME de Promocion Agricola Y Ganadera Del Tajo Sa
07 de Febrero de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GONZALEZ ONIEVA JOSE MARIA. Nombramientos. Adm. Mancom.: GONZALEZ ONIEVA JOSEMARIA;GONZALEZ-ONIEVA ARIZA NURIA-PALOMA. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nicoa Administradores mancomunados. Datos registrales. T 4831 , F 199, S 8, H M 79397, I/A 23 (31.01.22).
02 de Diciembre de 2019Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 20.064,66 Euros. Resultante Suscrito: 40.135,34 Euros. Datos registrales. T 4831 , F 198,S 8, H M 79397, I/A 22 (25.11.19).
17 de Marzo de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GONZALEZ ONIEVA JOSE MARIA. Nombramientos. Adm. Unico: GONZALEZ ONIEVA JOSEMARIA. Datos registrales. T 4831 , F 198, S 8, H M 79397, I/A 21 ( 9.03.17).
19 de Diciembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ ONIEVA JULIO JOSE. Presidente: GONZALEZ ONIEVA JULIO JOSE. Cons.Del.Man:GONZALEZ ONIEVA JULIO JOSE. Consejero: GONZALEZ ONIEVA JOSE MARIA. Secretario: GONZALEZ ONIEVA JOSE MARIA.Cons.Del.Man: GONZALEZ ONIEVA JOSE MARIA. Consejero: GONZALEZ ONIEVA NURIA PALOMA. Cons.Del.Man: GONZALEZONIEVA NURIA PALOMA. Nombramientos. Adm. Unico: GONZALEZ ONIEVA JOSE MARIA. Modificaciones estatutarias.Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Otros conceptos: POR ACUERDO DE LAJUNTA UNIVERSAL DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2011, SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 17, 18, 19, 21, 22, 23 Y 24 DE LOSESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 4831 , F 197, S 8, H M 79397, I/A 20 ( 2.12.11).
28 de Noviembre de 2011Cambio de domicilio social. C/ DARRO NUMERO 28 (MADRID). Datos registrales. T 4831 , F 197, S 8, H M 79397, I/A 19
06 de Mayo de 2011Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 6.020,00 Euros. Resultante Suscrito: 60.200,00 Euros. Datos registrales. T 4831 , F 195,S 8, H M 79397, I/A 18 (25.04.11).
25 de Abril de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ GONZALEZ JULIO. Con.Delegado: GONZALEZ GONZALEZ JULIO. Presidente:GONZALEZ GONZALEZ JULIO. Secretario: GONZALEZ ONIEVA JOSE MARIA. Consejero: GONZALEZ ONIEVA JULIOJOSE;GONZALEZ ONIEVA JOSE MARIA. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ ONIEVA JULIO JOSE. Presidente: GONZALEZONIEVA JULIO JOSE. Cons.Del.Man: GONZALEZ ONIEVA JULIO JOSE. Consejero: GONZALEZ ONIEVA JOSE MARIA. Secretario:GONZALEZ ONIEVA JOSE MARIA. Cons.Del.Man: GONZALEZ ONIEVA JOSE MARIA. Consejero: GONZALEZ ONIEVA NURIAPALOMA. Cons.Del.Man: GONZALEZ ONIEVA NURIA PALOMA. Datos registrales. T 4831 , F 194, S 8, H M 79397, I/A 17 (7.04.11).
15 de Abril de 2011Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 9.030,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 6.020,00 Euros.Desembolsado: 6.020,00 Euros. Resultante Suscrito: 66.220,00 Euros. Resultante Desembolsado: 66.220,00 Euros. Datosregistrales. T 4831 , F 193, S 8, H M 79397, I/A 16 ( 4.04.11).