Actos BORME de Promociones Coto De Los Ferranes Sl
28 de Noviembre de 2023Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 302/2016. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 17/11/2023. Auto de conclusi贸n delconcurso. Cumplimiento de convenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE OVIEDO. Juez: RAFAELABRIL MANSO. Resoluciones: Se declara la conclusi贸n del concurso por cumplimiento del convenio aprobado por sentencia de 15 demayo de 2017. Datos registrales. T 4087 , F 92, S 8, H AS 22732, I/A 20 (22.11.23).
22 de Octubre de 2020Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 3. Domicilio social.-. Cambio de domicilio social. C/ CORRIDA 59 5潞(GIJON). Datos registrales. T 4087 , F 92, S 8, H AS 22732, I/A 19 (14.10.20).
27 de Julio de 2017Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 302/2016. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 15/05/2017. Sentencia de aprobaci贸n delconvenio. Juzgado: num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON. Juez: RAFAEL ABRIL MANSO. Resoluciones: APROBAR LAPROPUESTA ANTICIPADA DE CONVENIO PRESENTADA POR LA CONCURSADA PROMOCIONES COTO DE LOS FERRANESSL. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 302/2016. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 15/05/2017. Cese de las limitacionesde las facultades de administraci贸n. Juzgado: num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON. Juez: RAFAEL ABRIL MANSO.Resoluciones: SE ACUERDA EL CESE DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACION DE CONCURSO SOBRE LAS FACULTADES DEADMINISTRACION Y DISPOSICION DEL DEUDOR ASI COMO DE LOS EFECTOS QUE TAL.DECLARACION PRODUCE EN LOSCONTRATOS EN LOS QUE ES PARTE LA ENTIDAD DECLARADA EN CONCURSO Y SOBRE LOS ACREEDORES DE LACONCURSADA, SI BIEN R. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 302/2016. Fecha de resoluci贸n 29/11/2016. Revocaci贸nde administradores concursales. Juzgado: num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON. Juez: RAFAEL ABRIL MANSO.Administrador Concursal. Fecha 15/05/2017, NIF/CIF B83311340. CASTRO ALONSO ASESORES SL. Datos registrales. T 4087 , F92, S 8, H AS 22732, I/A 18 (19.07.17).
06 de Febrero de 2017Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 302/2016. Fecha de resoluci贸n 29/11/2016. Nombramiento de administradores.Juzgado: num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON. Juez: RAFAEL ABRIL MANSO. Administrador Concursal. Fecha29/11/2016, NIF/CIF B83311340. CASTRO ALONSO ASESORES SL. Datos registrales. T 4087 , F 92, S 8, H AS 22732, I/A 17(27.01.17).
16 de Enero de 2017Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 302/2016. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 21/11/2016. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON. Juez: RAFAEL ABRIL MANSO. Resoluciones:Declarar en concurso al deudor PROMOCIONES COTO DE LOS FERRANES SL, toda vez que ha sido acreditado su estado de
09 de Septiembre de 2016Revocaciones. Auditor: AUDIASTUR ECONOMISTAS Y AUDITORES SL. Datos registrales. T 4087 , F 92, S 8, H AS 22732, I/A 15( 2.09.16).
03 de Marzo de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: METROVACESA SA;CENTROS COMERCIALES METROPOLITANOS SA;EXPLOTACIONESURBANAS ESPA脩OLAS SL;15 DE FONDO SL;PROMOCIONES MIRADOR DE LOS FERRANES SL;UNIDAD DE NEGOCIOS DELNORTE SL. Presidente: 15 DE FONDO SL. Con.Delegado: 15 DE FONDO SL. Secretario: MU脩OZ PAREDES JOSE MARIA.Nombramientos. Adm. Solid.: 15 DE FONDO SL;UNIDAD DE NEGOCIOS DEL NORTE SL. Modificaciones estatutarias. Cambiodel Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 4087 , F 91, S 8, H AS22732, I/A 13 (20.02.15).
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: UNIDAD DE NEGOCIOS DEL NORTE SL. Nombramientos. Adm. Solid.: PROMOCIONESMIRADOR DE LOS FERRANES SL. Datos registrales. T 4087 , F 91, S 8, H AS 22732, I/A 14 (20.02.15).
13 de Noviembre de 2014Reelecciones. Auditor: AUDIASTUR ECONOMISTAS Y AUDITORES SL. Datos registrales. T 4087 , F 91, S 8, H AS 22732, I/A 12 (4.11.14).
10 de Octubre de 2014Ceses/Dimisiones. Representan: NU脩O PEREZ FERNANDO. Otros conceptos: RENUNCIA DEL REPRESENTANTE FISICO DELCONSEJERO PROMOCIONES MIRADOR DE LOS FERRANES SL. Datos registrales. T 4087 , F 91, S 8, H AS 22732, I/A 11 (2.10.14).
05 de Septiembre de 2014Revocaciones. Apoderado: NU脩O PEREZ FERNANDO. Datos registrales. T 4087 , F 91, S 8, H AS 22732, I/A 10 (28.08.14).
03 de Septiembre de 2014Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 3. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ CORRIDA 27-29 Esc.IZ 2潞(GIJON). Datos registrales. T 4087 , F 91, S 8, H AS 22732, I/A 9 (26.08.14).
29 de Octubre de 2013Reelecciones. Auditor: AUDIASTUR ECONOMISTAS Y AUDITORES SL. Datos registrales. T 19744 , F 73, S 8, H M 347486, I/A 21(21.10.13).
21 de Junio de 2013Ceses/Dimisiones. Representan: HORTIGUELA REVILLA VICTOR. Nombramientos. Representan: CRIADO DOCANDO JUAN.Datos registrales. T 19744 , F 73, S 8, H M 347486, I/A 20 (13.06.13).
09 de Abril de 2013Ceses/Dimisiones. Representan: LIEDO ALVAREZ MANUEL. Nombramientos. Representan: HORTIGUELA REVILLA VICTOR.Datos registrales. T 19744 , F 72, S 8, H M 347486, I/A 19 ( 2.04.13).
14 de Diciembre de 2012Reelecciones. Auditor: AUDIASTUR ECONOMISTAS Y AUDITORES SL. Datos registrales. T 19744 , F 72, S 8, H M 347486, I/A 18(30.11.12).
31 de Mayo de 2012Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ VALLINA SUAREZ PABLO. Datos registrales. T 19744 , F 71, S 8, H M 347486, I/A 17(21.05.12).
08 de Marzo de 2012Reelecciones. Auditor: AUDIASTUR ECONOMISTAS Y AUDITORES SL. Datos registrales. T 19744 , F 71, S 8, H M 347486, I/A 16(27.02.12).
30 de Marzo de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ VALLINA JORGE LUIS. Con.Delegado: FERNANDEZ VALLINA JORGE LUIS.Consejero: FERNANDEZ VALLINA CARLOS;NU脩O PEREZ FERNANDO. Nombramientos. Consejero: 15 DE FONDOSL;PROMOCIONES MIRADOR DE LOS FERRANES SL;UNIDAD DE NEGOCIOS DEL NORTE SL. Presidente: 15 DE FONDO SL.Representan: FERNANDEZ VALLINA JORGE LUIS;NU脩O PEREZ FERNANDO;FERNANDEZ VALLINA CARLOS. Con.Delegado: 15DE FONDO SL. Datos registrales. T 19744 , F 70, S 8, H M 347486, I/A 15 (18.03.11).
22 de Octubre de 2010Ceses/Dimisiones. Representan: PEREZ RODRIGUEZ JESUS. Nombramientos. Representan: BUENO MONTAVEZ RAQUEL.Datos registrales. T 19744 , F 70, S 8, H M 347486, I/A 14 (11.10.10).
28 de Diciembre de 2009Reelecciones. Auditor: AUDIASTUR ECONOMISTAS Y AUDITORES SL. Datos registrales. T 19744 , F 69, S 8, H M 347486, I/A 13(15.12.09).
16 de Septiembre de 2009Ceses/Dimisiones. Representan: MORENO ESCOBAR FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Representan: PEREZRODRIGUEZ JESUS. Otros conceptos: CAMBIO DE REPRESENTANTE FISICO DE LA ENTIDAD "EXPLOTACIONESURBANASESPA脩OLAS SL" Datos registrales. T 19744 , F 69, S 8, H M 347486, I/A 11 ( 4.09.09).
Ceses/Dimisiones. Representan: VALDERRABANO GONZALEZ RAFAEL. Nombramientos. Representan: VICENTE ASENJOJESUS. Otros conceptos: CAMBIO DE REPRESENTANTE FISICO DE LA SOCIEDAD "METROVACESA SA". Datos registrales.T 19744 , F 69, S 8, H M 347486, I/A 12 ( 4.09.09).