Actos BORME de Promociones Europeas De Hoteleria Sl
07 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CABALLE HORTA JOSE MARIA. Extinci贸n. Datos registrales. T 3718 , F 102, S 8, H A 1246, I/A21 (27.09.19).
10 de Septiembre de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: CABALLE TURA NATALIA;VELEZ CANTOS PEDRO;LLORCA RAMIREZ JAIME. Apo.Manc.: CABALLETURA NATALIA;VELEZ CANTOS PEDRO;LLORCA RAMIREZ JAIME. Datos registrales. T 3718 , F 102, S 8, H A 1246, I/A 20(30.08.18).
06 de Septiembre de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: CABALLE TURA NATALIA;LLORCA RAMIREZ JAIME;PEREZ RIPOLL ANA MARIA. Apo.Manc.:CABALLE TURA NATALIA;LLORCA RAMIREZ JAIME;PEREZ RIPOLL ANA MARIA. Datos registrales. T 3718 , F 101, S 8, H A1246, I/A 19 (29.08.18).
17 de Mayo de 2018Nombramientos. Apoderado: CABALLE HORTA JORGE. Datos registrales. T 3718 , F 100, S 8, H A 1246, I/A 18 ( 8.05.18).
25 de Octubre de 2013Revocaciones. Apo.Man.Soli: CABALLE HORTA JORGE;CABALLE TURA JOSE MARIA;VELEZ CANTOS PEDRO;LLORCARAMIREZ JAIME. Datos registrales. T 3718 , F 100, S 8, H A 1246, I/A 17 (18.10.13).
22 de Octubre de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: CABALLE TURA NATALIA;VELEZ CANTOS PEDRO;LLORCA RAMIREZ JAIME. Apo.Manc.: CABALLETURA NATALIA;VELEZ CANTOS PEDRO;LLORCA RAMIREZ JAIME. Datos registrales. T 3718 , F 99, S 8, H A 1246, I/A 16(15.10.13).
16 de Octubre de 2013Nombramientos. Apoderado: CABALLE HORTA JORGE. Datos registrales. T 2864 , F 200, S 8, H A 1246, I/A 15 (10.10.13).
10 de Junio de 2013Otros conceptos: Modificaci贸n de la totalidad de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 2864 , F 198, S 8, H A 1246, I/A 14 (3.06.13).