Actos BORME de Promociones Fotovoltaicas Corylus Sl
23 de Noviembre de 2023Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 41795 , F 104, S 8, H M 548956, I/A 19 (16.11.23).
13 de Agosto de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: ESPINOSA PRADOS ROCIO;GIL ACACIO MARIA DEL PILAR;REVILLO ALEGRE JOSELUIS;MARTIN-PE脩ATO ECHEVARRIA TOMAS;ORTIZ HURTADO ITZIAR;OLEA AVILES JOSE MANUEL;ALVAREZ SANCHEZ ANA.Datos registrales. T 41795 , F 102, S 8, H M 548956, I/A 18 ( 6.08.21).
23 de Junio de 2021Nombramientos. Apoderado: REVILLO ALEGRE JOSE LUIS. Datos registrales. T 30505 , F 12, S 8, H M 548956, I/A 17
31 de Diciembre de 2020Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 30505 , F 12, S 8, H M 548956, I/A 16 (23.12.20).
11 de Marzo de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 30505 , F 12, S 8, H M 548956, I/A 15 ( 4.03.20).
25 de Febrero de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: SANMARTIN CASTRO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 30505 , F 12, S 8, H M 548956, I/A 14(18.02.20).
19 de Febrero de 2020Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: RENOVALIA PV BROWNFIELD SL. Datos registrales. T 30505 , F12, S 8, H M 548956, I/A 13 (12.02.20).
20 de Marzo de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: OLEA AVILES JOSE MANUEL;GALOBART SANCHEZ-MARCO JAIME. Nombramientos. Adm.Mancom.: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:
15 de Enero de 2018Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 30505 , F 11, S 8, H M 548956,I/A 11 ( 4.01.18).
01 de Marzo de 2017Modificaciones estatutarias. 7. Acciones/Participaciones.. Datos registrales. T 30505 , F 10, S 8, H M 548956, I/A 10 (21.02.17).
17 de Febrero de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: SANMARTIN CASTRO JUAN CARLOS;GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 30505 , F9, S 8, H M 548956, I/A 9 (10.02.17).
19 de Enero de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: FERNANDES MILTON ANTHONY;ECHEGOYEN LEWIN RAFAEL TRISTAN. Revocaciones.Apoderado: ROESSNER NIKOLAUS;NELSON STEPHEN. Apo.Sol.: ECHEGOYEN LEWIN RAFAEL TRISTAN;PEREZ IGLESIAMIGUEL SANTIAGO. Nombramientos. Adm. Solid.: OLEA AVILES JOSE MANUEL;GALOBART SANCHEZ-MARCO JAIME. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados a Administradores solidarios. Cambio dedomicilio social. C/ MARIA DE MOLINA 54 9陋 (MADRID). Datos registrales. T 30505 , F 9, S 8, H M 548956, I/A 8 ( 9.01.17).
28 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: ECHEGOYEN LEWIN RAFAEL TRISTAN;PEREZ IGLESIA MIGUEL SANTIAGO. Otros conceptos:REVOCADO EL PODER CONFERIDO A DON FRANCISCO BORJA ESCALADA JIMENEZ Y DON JORGE VALLEJO LOPEZ ENVIRTUD DE ESCRITURA AUTORIZADA POR EL NOTARIO DE MADRID DON IGNACIO SOLIS VILLA EL 2 DE NOVIEMBRE DE2011 CON EL NUMERO 849 DE PROTOCOLO. Datos registrales. T 30505 , F 8, S 8, H M 548956, I/A 7 (17.12.15).
14 de Octubre de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: BRADBURY KENTON;ARRIOLA GARROTE JUAN MANUEL. Revocaciones. Apoderado:DELLACHA MARIA GEORGINA. Nombramientos. Adm. Mancom.: FERNANDES MILTON ANTHONY;ECHEGOYEN LEWINRAFAEL TRISTAN. Apoderado: NELSON STEPHEN. Otros conceptos: Revocado el poder conferido a don Kenton EdwardBradbury que caus贸 en este Registro la inscripci贸n 1& y 2& de traslado, inscripci贸n 8& en la Hoja del Registro Mercantil de Navarra.Datos registrales. T 30505 , F 7, S 8, H M 548956, I/A 6 ( 5.10.15).
04 de Septiembre de 2014Revocaciones. Apo.Sol.: BOTIJA DE-SANTOS ANTONIO. Datos registrales. T 30505 , F 6, S 8, H M 548956, I/A 5 (27.08.14).
22 de Enero de 2014Nombramientos. Apoderado: ROESSNER NIKOLAUS. Datos registrales. T 30505 , F 6, S 8, H M 548956, I/A 4 (15.01.14).
01 de Marzo de 2013Nombramientos. Apoderado: DELLACHA MARIA GEORGINA. Datos registrales. T 30505 , F 5, S 8, H M 548956, I/A 3 (21.02.13).
05 de Diciembre de 2012Cambio de domicilio social. C/ SERRANO 27 4 (MADRID). Datos registrales. T 30505 , F 5, S 8, H M 548956, I/A 2 (26.11.12).
19 de Noviembre de 2012Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: EARTH AND WIND ENERGIAS RENOVABLES SL. Nombramientos. Adm. Mancom.:BRADBURY KENTON. Apoderado: BOTIJA DE SANTOS ANTONIO;BRADBURY KENTON;ESCALADA JIMENEZ FRANCISCO DEBORJA;VALLEJO LOPEZ JORGE. Datos registrales. T 1256 , F 59, S 8, H NA 25019, I/A 8 ( 6.11.12).
08 de Septiembre de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 18.732,00 Euros. Resultante Suscrito: 75.752,00 Euros. Datos registrales. T 1256 , F 58, S 8, H NA25019, I/A 7 (26.08.11).
05 de Agosto de 2011Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: EARTH AND WIND ENERGIAS RENOVABLES SL.Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CHAVEZ MARTINEZ ALEJANDRO JAVIER. Nombramientos. Adm. Mancom.: ARRIOLAGARROTE JUAN MANUEL;EARTH AND WIND ENERGIAS RENOVABLES SL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 1256 , F 58, S 8, H NA 25019, I/A 6(20.07.11).
28 de Abril de 2011Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: OPDE INVESTMENT ESPA脩A SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico:RIOS GIL ADALBERTO. Nombramientos. Adm. Unico: CHAVEZ MARTINEZ ALEJANDRO JAVIER. Datos registrales. T 1256 , F58, S 8, H NA 25019, I/A 5 (13.04.11).
10 de Marzo de 2009Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: VALSINGULA SL. Cif:B31963093. Ceses/Dimisiones. Admin.Solid:CASANOVA AGUSTI JOSE IGNACIO;TURMO SOLDEVILA JOSEP. Nombramientos. Admin.Unico: RIOS GIL ADALBERTO.Modificaciones estatutarias. MODIFICACION ESTRUCTURA ORGANO ADMINISTRACION. ADMINISTRADOR UNICO. Cambiode domicilio social. POLIGONO INDUSTRIAL SANTOS JUSTO Y PASTOR, S/N (FUSTI脩ANA). Datos registrales. T 1256 , F 57, S8, H NA025019, I/A00004 (27.02.09).