Actos BORME de Promoiler Sl
27 de Junio de 2019Cierre provisional de la hoja registral por revocaci贸n del NIF. Datos registrales. T 550 , F 212, S 8, H L 10244, I/A N.M.(20.06.19).
13 de Diciembre de 2016Cierre provisional hoja registral por baja en el 铆ndice de Entidades Jur铆dicas. Datos registrales. T 550 , F 211, S 8, H L 10244,I/A NM ( 1.12.16).
03 de Octubre de 2011Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: ARBOGA INVERSIONES SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico:GARCIA HUERTAS RAFAEL. Nombramientos. Adm. Unico: LEYVA BRIEGA MANUEL. Datos registrales. T 550 , F 211, S 8, H L10244, I/A 8 (23.09.11).
05 de Septiembre de 2011Revocaciones. Apoderado: ROCA CORTES JOSEP. Datos registrales. T 550 , F 211, S 8, H L 10244, I/A 7 (26.08.11).
29 de Julio de 2011Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: PROMORUF 111 SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: ROCA CORTES CELESTINO.Presidente: ROCA CORTES CELESTINO. Cons.Del.Man: ROCA CORTES CELESTINO. Consejero: CORTES TORRASANTONIA;ROCA CORTES MARIA DOLORS;LACASA FERRANDO ROSER. Vicepresid.: LACASA FERRANDO ROSER. Consejero:CASANOVES CUBERES MARIA ANGELES. Cons.Del.Man: CASANOVES CUBERES MARIA ANGELES. Secretario: CASANOVESCUBERES MARIA ANGELES. Nombramientos. Adm. Unico: GARCIA HUERTAS RAFAEL. Modificaciones estatutarias. Cambiodel Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 550 , F 211, S 8, H L 10244, I/A
29 de Abril de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA HUERTAS RAFAEL. Cons.Del.Man: GARCIA HUERTAS RAFAEL. Vicepresid.: GARCIAHUERTAS RAFAEL. Cons.Del.Man: ROCA CORTES CELESTINO. Nombramientos. Vicepresid.: LACASA FERRANDO ROSER.Secretario: CASANOVES CUBERES MARIA ANGELES. Cons.Del.Man: ROCA CORTES CELESTINO;CASANOVES CUBERESMARIA ANGELES. Otros conceptos: Fijado en 5 el n煤mero de Consejeros. Aceptada la renuncia presentada por Don VenanciBlanch Bonet, a sus cargos de Consejero, Secretario del Consejo de Administraci贸n y Consejero Delegado, mediante escrituraautorizada por el Notario de Lleida, Don Pablo G贸mez Claver铆a, n煤mero 214 de protocolo. Cambio de domicilio social. C/ JOANMIRO 9 BAIXOS (LLEIDA). Datos registrales. T 550 , F 164, S 8, H L 10244, I/A 5 (19.04.10).
08 de Marzo de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: BLANCH BONET VENANCIO. Secretario: BLANCH BONET VENANCIO. Cons.Del.Man: BLANCHBONET VENANCIO. Datos registrales. T 550 , F 164, S 8, H L 10244, I/A 4 (25.02.10).
15 de Abril de 2009Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 0,07 Euros. Resultante Suscrito: 3.606,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:196.406,80 Euros. Resultante Suscrito: 200.012,80 Euros. Datos registrales. T 550 , F 163, S 8, H L 10244, I/A 3 ( 2.04.09).