Buscador CIF Logo

Actos BORME Promontoria Bee Sociedad Limitada

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Promontoria Bee Sociedad Limitada

Actos BORME Promontoria Bee Sociedad Limitada - B86237781

Tenemos registrados 16 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Promontoria Bee Sociedad Limitada con CIF B86237781

🔙 Perfil de Promontoria Bee Sociedad Limitada
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Promontoria Bee Sociedad Limitada

30 de Octubre de 2023
Ceses/Dimisiones. Presidente: SCHIPPER GERARDUS JOHANESS. Vicepresid.: SPV SPAIN 5 SL. Representan: PUIG RUANOURSULA. Nombramientos. Presidente: SPV SPAIN 5 SL. Vicepresid.: SCHIPPER GERARDUS JOHANNES. Representan: PUIGRUANO URSULA. Datos registrales. T 28942 , F 225, S 8, H M 521143, I/A 20 (23.10.23).

06 de Febrero de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: ASTARLOA ECHEVARRIETA MARIA;FERRER SAMA SERVER CRISTINA. Cons.Del.Man: FERRERSAMA SERVER CRISTINA;ASTARLOA ECHEVARRIETA MARIA. Secretario: FERRER SAMA SERVER CRISTINA.Nombramientos. Representan: ASTARLOA ECHEVARRIETA MARIA-GUADALUPE. Consejero: SPV SPAIN 5 SL;INTERTRUST(SPAIN) SL. Vicepresid.: SPV SPAIN 5 SL. Secretario: INTERTRUST (SPAIN) SL. Cons.Del.Man: SPV SPAIN 5 SL;INTERTRUST(SPAIN) SL. Representan: PUIG RUANO URSULA. Modificaciones estatutarias. 18.-. Administradores.. Datos registrales. T28942 , F 223, S 8, H M 521143, I/A 18 (30.01.20).

Nombramientos. Apo.Manc.: SCHIPPER GERARDUS JOHANNES;VAN VLIET JASPER JAN;BAAIJENS LUKASCHRISTIAAN;HOFLAND RAOUL RENE;HONING IRMA DESIREE;VAN DER DONK WILCO ADRIANUS WILHELMUS MARIA;VAN DEWERKEN ARJEN;VAN DER HEIJDE PATRICK;ASTARLOA ECHEVARRIETA MARIA-GUADALUPE;PUIG RUANO URSULA. Datosregistrales. T 28942 , F 224, S 8, H M 521143, I/A 19 (30.01.20).

11 de Diciembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: PEREDO PEREZ ALVARO;VIZCAINO MARTIN JUAN FRANCISCO. Nombramientos. Apoderado:HIPOGES IBERIA SL. Datos registrales. T 28942 , F 221, S 8, H M 521143, I/A 16 (29.11.19).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: VIZCAINO MARTIN JUAN FRANCISCO;LORES ORTAS JAVIER;PEREDO PEREZALVARO;NEWTON ANDREW DOUGLAS. Nombramientos. Apo.Manc.: SCHIPPER GERARDUS JOHANNES;VAN VLIET JASPERJAN;BAAIJENS LUKAS CHRISTIAAN;HOFLAND RAOUL RENE;HONING IRMA DESIREE;VAN DER DONK WILCO ADRIANUSWILHELMUS MARIA;VAN DE WERKEN ARJEN;VAN DER HEIJDE PATRICK;HIPOGES IBERIA SL. Datos registrales. T 28942 , F222, S 8, H M 521143, I/A 17 (29.11.19).

06 de Julio de 2018
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social .-. Cambio de domicilio social. C/ SERRANO 41 4º(MADRID). Datos registrales. T 28942 , F 221, S 8, H M 521143, I/A 15 (29.06.18).

13 de Junio de 2017
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: MILLSTEIN LEE SCOTT. Consejero: MILLSTEIN LEE SCOTT. Nombramientos. Consejero:VAN VLIET JASPER JAN. Cons.Del.Man: VAN VLIET JASPER JAN. Datos registrales. T 28942 , F 220, S 8, H M 521143, I/A 14 (5.06.17).

02 de Diciembre de 2015
Revocaciones. Apoderado: CORTINA URDANPILLETA EVENCIO;MEYLAN TOBOSO IGNACIO;RODRIGUEZ VEGA MONICA.Apo.Man.Soli: DE PABLO MADRIGAL FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Apoderado: AVILES RUIZ DIEGO. Datosregistrales. T 28942 , F 219, S 8, H M 521143, I/A 13 (24.11.15).

04 de Septiembre de 2014
Ampliación de capital. Capital: 30.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 93.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo delos estatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T 28942 , F 217, S 8, H M 521143, I/A 12 (28.08.14).

28 de Abril de 2014
Nombramientos. Apo.Man.Soli: REVILLA MELIAN ANTONIA DE LOS ANGELES;DE PABLO MADRIGAL FRANCISCOJAVIER;JIMENEZ ARESPACOCHAGA JUAN. Datos registrales. T 28942 , F 217, S 8, H M 521143, I/A 11 (21.04.14).

07 de Noviembre de 2013
Revocaciones. Apoderado: HOFLAND RAOUL RENE;VAN DE WERKEN ARJEN. Nombramientos. Apo.Manc.: HOFLAND RAOULRENE;VAN DE WERKEN ARJEN;SCHIPPER GERARDUS-JOHANNES;VAN VLIET JASPER JAN. Datos registrales. T 28942 , F216, S 8, H M 521143, I/A 10 (29.10.13).

10 de Octubre de 2013
Nombramientos. Apoderado: HOFLAND RAOUL RENE;VAN DE WERKEN ARJEN. Datos registrales. T 28942 , F 215, S 8, H M521143, I/A 9 ( 2.10.13).

23 de Noviembre de 2012
Ampliación de capital. Capital: 60.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 63.000,00 Euros. Otros conceptos: RENUMERACION DELAS PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA SOCIEDADY ASIGNACION DEL VALOR DE LAS PARTICIPACIONES. Datosregistrales. T 28942 , F 215, S 8, H M 521143, I/A 8 (14.11.12).

26 de Abril de 2012
Nombramientos. Apo.Man.Soli: VIZCAINO MARTIN JUAN FRANCISCO;LORES ORTAS JAVIER;PEREDO PEREZALVARO;NEWTON ANDREW DOUGLAS. Apo.Manc.: SCHIPPER GERARDUS JOHANESS;MILLSTEIN LEE SCOTT. Datosregistrales. T 28942 , F 56, S 8, H M 521143, I/A 7 (10.04.12).

24 de Febrero de 2012
Nombramientos. Apoderado: CORTINA URDANPILLETA EVENCIO;PEREDO PEREZ ALVARO;VIZCAINO MARTIN JUANFRANCISCO;MEYLAN TOBOSO IGNACIO;RODRIGUEZ VEGA MONICA. Datos registrales. T 28942 , F 55, S 8, H M 521143, I/A 6(14.02.12).

17 de Febrero de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: VAN VLIET JASPER JAN. Cons.Del.Man: VAN VLIET JASPER JAN. SecreNoConsj: SALAMANCACUEVAS MARIA LORENA. Nombramientos. Secretario: FERRER SAMA SERVER CRISTINA. Otros conceptos: MODIFICACIONEN EL REGIMEN DE ACTUACION DE LOS CONSEJEROS DELEGADOS MANCOMUNADOS. Datos registrales. T 28942 , F 54, S

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información