Buscador CIF Logo

Actos BORME Promoreras Desarrollo De Activos Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Promoreras Desarrollo De Activos Sl

Actos BORME Promoreras Desarrollo De Activos Sl - B85413383

Tenemos registrados 8 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Promoreras Desarrollo De Activos Sl con CIF B85413383

馃敊 Perfil de Promoreras Desarrollo De Activos Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Promoreras Desarrollo De Activos Sl

08 de Octubre de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LA TORRE MARTINEZ MANUEL;RUBIO ALBERT RAFAEL;SOLER CRESPO BAUTISTA.Presidente: DE LA TORRE MARTINEZ MANUEL. Consejero: INTEGRA S. I. SA. SecreNoConsj: CORRAL ESCRIBANO MAURICIO.VsecrNoConsj: MORENO DE LA OSA RAUL. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 27081 , F 146, S 8, H M 459251,I/A 11 (30.09.13).

08 de Agosto de 2013
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE SA. Datos registrales. T 27081 , F 145,S 8, H M 459251, I/A 10 ( 1.08.13).

30 de Abril de 2012
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: DIAZ AMBRONA MORENO ADOLFO. Nombramientos. SecreNoConsj: CORRAL ESCRIBANOMAURICIO. Datos registrales. T 27081 , F 145, S 8, H M 459251, I/A 9 (17.04.12).

26 de Diciembre de 2011
Nombramientos. Apo.Manc.: DE LA TORRE MARTINEZ MANUEL;GOMEZ RUIZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 27081 , F 145, S8, H M 459251, I/A 8 (15.12.11).

27 de Enero de 2011
Nombramientos. Apo.Manc.: DE LA TORRE MARTINEZ MANUEL;ESCOBAR LASALA LUIS. Datos registrales. T 27081 , F 143, S8, H M 459251, I/A 7 (18.01.11).

26 de Enero de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: NOGUERA LLIBRER VICENTA. Secretario: RUBIO ALBERT RAFAEL. Nombramientos. Consejero:INTEGRA S. I. SA. Representan: GOMENDIO LOPEZ DE ASIAIN PABLO. SecreNoConsj: DIAZ AMBRONA MORENO ADOLFO.

16 de Febrero de 2010
Nombramientos. Apoderado: DE LA TORRE MARTINEZ MANUEL;GOMEZ RUIZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 27081 , F 140, S8, H M 459251, I/A 5 ( 4.02.10).

01 de Febrero de 2010
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GOMEZ RUIZ JOSE LUIS;DE LA TORREMARTINEZ MANUEL. Nombramientos. Consejero: DE LA TORRE MARTINEZ MANUEL;RUBIO ALBERT RAFAEL;NOGUERALLIBRER VICENTA;SOLER CRESPO BAUTISTA. Presidente: DE LA TORRE MARTINEZ MANUEL. Secretario: RUBIO ALBERTRAFAEL. Ampliaci贸n de capital. Capital: 13.996.994,00 Euros. Resultante Suscrito: 14.000.000,00 Euros. Modificacionesestatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados a Consejo de administraci贸n. Cambio dedomicilio social. C/ CALENDULA 93 - EDIFICIO F, MINIPARC III, URBANI (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 25488 , F 163, S8, H M 459251, I/A 4 (20.01.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n