Actos BORME de Promotora Arnedillo Sociedad Anonima
28 de Septiembre de 2023Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.287.943,00 Euros. Resultante Suscrito: 898.422,88 Euros. Datos registrales. T 4141 , F90, S 8, H BI 3476,A , I/ 19 .(20.09.23).
09 de Agosto de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 800.003,12 Euros. Resultante Suscrito: 2.186.365,88 Euros. Datos registrales. T 4141 , F89, S 8, H BI 3476,A , I/ 18 .(27.07.22).
24 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: DEL POZO RODRIGUEZ MIGUEL. Presidente: DEL POZO RODRIGUEZ MIGUEL. Vicepresid.: DELPOZO CAMPUS ROBERTO. Vicesecret.: DEL POZO CAMPUS IRENE. Nombramientos. Presidente: DEL POZO CAMPUSROBERTO. Vicepresid.: DEL POZO CAMPUS IRENE. Datos registrales. T 4141 , F 88, S 8, H BI 3476,A , I/ 17 .(14.10.19).
04 de Mayo de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DEL POZO RODRIGUEZ MIGUEL. Nombramientos. Consejero: DEL POZO RODRIGUEZMIGUEL. Presidente: DEL POZO RODRIGUEZ MIGUEL. Consejero: DEL POZO CAMPUS ROBERTO. Vicepresid.: DEL POZOCAMPUS ROBERTO. Consejero: DEL POZO CAMPUS GUILLERMINA. Secretario: DEL POZO CAMPUS GUILLERMINA. Consejero:DEL POZO CAMPUS IRENE. Vicesecret.: DEL POZO CAMPUS IRENE. Consejero: DEL POZO CAMPUS MIGUEL ANGEL. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Adaptaci贸n a la nueva Ley deSociedades de Capital. Datos registrales. T 3704, L 1, F 117, S 8, H BI 3476,A , I/ 15 .(24.04.18).
Nombramientos. Con.Delegado: DEL POZO CAMPUS MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 3704, L 1, F 120, S 8, H BI 3476,A , I/16 .(25.04.18).
30 de Abril de 2013Reelecciones. Adm. Unico: DEL POZO RODRIGUEZ MIGUEL. Datos registrales. T 3704, L 1, F 117, S 8, H BI 3476,A , I/ 14.(17.04.13).
01 de Julio de 2011Revocaciones. Apo.Sol.: DEL POZO CAMPUS MIGUEL ANGEL;DEL POZO CAMPUS ROBERTO. Nombramientos. Apoderado:DEL POZO CAMPUS MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 3704, L 1, F 116, S 8, H BI 3476,A , I/ 13 .(14.06.11).