Actos BORME de Promotora Bulevar De Burgos Sl
18 de Septiembre de 2020Revocaciones. Apoderado: HORTIGUELA GONZALEZ JUAN CARLOS;HORTIGUELA GONZALEZ JUAN CARLOS. Datosregistrales. T 695, L 486, F 37, S 8, H BU 13623, I/A 13 (11.09.20).
Nombramientos. Apoderado: PUENTE ANTON JESUS MARIA. Datos registrales. T 695, L 486, F 37, S 8, H BU 13623, I/A 14(11.09.20).
09 de Octubre de 2018Cambio de domicilio social. C/ VITORIA 4 3 - OFICINA 305 (BURGOS). Datos registrales. T 695, L 486, F 37, S 8, H BU 13623,I/A 12 ( 3.10.18).
29 de Enero de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: ARRANZ MONJE JESUS;GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Adm.Unico: ARRANZ MONJE JESUS. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 695, L 486, F 37, S 8, H BU 13623, I/A 11 (23.01.18).
27 de Diciembre de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: MARPI SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SL. Datos registrales. T 695, L 486, F 36, S 8, H BU13623, I/A 10 (20.12.17).
27 de Septiembre de 2016Modificaciones estatutarias. 8. En caso de varios administradores conjuntos, que podr谩n oscilar entre dos y cuatro, el poder derepresentaci贸n se ejercer谩 mancomunadamente por dos de ellos. . Datos registrales. T 695, L 486, F 36, S 8, H BU 13623, I/A 8(14.09.16).
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GOMEZ BILBAO ALFONSO;MARTIN DE RIOJA ANA. Revocaciones. Adm. Mancom.:ARRANZ RIOCEREZO ANTONIO. Datos registrales. T 695, L 486, F 36, S 8, H BU 13623, I/A 9 (14.09.16).
02 de Septiembre de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: PIEDRA CABESTRERO JOSE;MARCOS SERNA EMILIO;GONZALEZ RAMIREZ FERNANDO.Nombramientos. Adm. Mancom.: GOMEZ BILBAO ALFONSO;MARPI SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SL;MARTIN DE RIOJA ANA.Datos registrales. T 620, L 411, F 123, S 8, H BU 13623, I/A 7 (26.08.15).
12 de Enero de 2012Cambio de domicilio social. C/ BARRIO GIMENO 3 (BURGOS). Datos registrales. T 620, L 411, F 123, S 8, H BU 13623, I/A 6 (2.01.12).
30 de Mayo de 2011Nombramientos. Apoderado: HORTIGUELA GONZALEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 620, L 411, F 122, S 8, H BU 13623,I/A 3 (19.05.11).
Revocaciones. Apoderado: DE DOMINGO ANGULO FERNANDO. Datos registrales. T 620, L 411, F 123, S 8, H BU 13623, I/A 4(19.05.11).
Nombramientos. Apoderado: HORTIGUELA GONZALEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 620, L 411, F 123, S 8, H BU 13623,I/A 5 (19.05.11).
31 de Marzo de 2011Nombramientos. Apoderado: DE DOMINGO ANGULO FERNANDO. Datos registrales. T 620, L 411, F 121, S 8, H BU 13623, I/A 2(22.03.11).
24 de Mayo de 2010Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 24.03.10. Objeto social: El tr谩fico sobre bienes inmuebles, promoci贸n urban铆stica yrealizaci贸n de obras por cuenta propia o de terceros. Domicilio: C/ LA MERCED 9 - ENTREPLANTA A (BURGOS). Capital: 3.600,00Euros. Nombramientos. Adm. Mancom.: ARRANZ MONJE JESUS;ARRANZ RIOCEREZO ANTONIO;GONZALEZ RAMIREZFRANCISCO JAVIER;GONZALEZ RAMIREZ FERNANDO;PIEDRA CABESTRERO JOSE;MARCOS SERNA EMILIO. Datosregistrales. T 620, L 411, F 118, S 8, H BU 13623, I/A 1 (13.05.10).